TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03503231 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 140 London Wall EC2Y 5DN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PPM (PRIME) TRADING LIMITED | 28. Jan. 1998 | 28. Jan. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ernitia Ferguson als Sekretär am 01. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Aaron Jon Burns als Sekretär am 01. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bastion House 140 London Wall London EC2Y 5DN* am 23. Okt. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Ernitia Ferguson als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Frost als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Apr. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Warren Persky am 18. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNS, Aaron Jon | Sekretär | London Wall EC2Y 5DN London 140 | 193862900001 | |||||||
| PERSKY, Warren Ashley | Geschäftsführer | London Wall EC2Y 5DN London 140 United Kingdom | United Kingdom | British | 108635640073 | |||||
| TRILLIUM GROUP LIMITED | Geschäftsführer | London Wall EC2Y 5DN London 140 | 103653140001 | |||||||
| TRILLIUM HOLDINGS LIMITED | Geschäftsführer | London Wall EC2Y 5DN London 140 | 103653930002 | |||||||
| BARLOW, Tracey Anne Kingsley | Sekretär | 25 Holmesdale Avenue SW14 7BQ London | British | 65520910002 | ||||||
| BINGLEY, Joan Hilary | Sekretär | Eaton Farm Miles Lane KT11 2ED Cobham Surrey | Irish | 1388610001 | ||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Sekretär | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||
| FERGUSON, Ernitia | Sekretär | London Wall EC2Y 5DN London 140 United Kingdom | 168435690001 | |||||||
| FROST, William | Sekretär | Bastion House 140 London Wall London EC2Y 5DN | British | 134060040001 | ||||||
| WILSON, Gavin Edward Reid | Sekretär | 38 Upper Cheyne Row SW3 5JJ London | British | 56166890001 | ||||||
| BLAXLAND, Simon Thomas | Geschäftsführer | 237 Rue Du Foubourg Saint Honore 75008 Paris FOREIGN France | British | 58254750001 | ||||||
| CHANDE, Manish Jayantilal | Geschäftsführer | 9 Chester Place Regents Park NW1 4NB London | British | 83291490001 | ||||||
| ELLIS, Ian David | Geschäftsführer | Oak Lodge, Moor Road Great Tey CO6 1JJ Colchester Essex | England | British | 68191870001 | |||||
| FRANCO, Jon Jacob | Geschäftsführer | Flat 10 31 Collingham Road SW5 0NU London | American | 64630220002 | ||||||
| FRIEDLOS, Nicholas Robert | Geschäftsführer | 13 Alwyne Road N1 2HH London | England | British | 61183260002 | |||||
| FROST, William | Geschäftsführer | Kenley Road SW19 3DU London 77 | British | 134060040001 | ||||||
| GARMAN, James Robert | Geschäftsführer | Flat 5 56 Lexham Gardens W8 5JA London | British | 68523620003 | ||||||
| GEORGI, Richard Evans | Geschäftsführer | Church Gate Hall Church Gate SW6 3LD London | British | 56166880001 | ||||||
| GODDEN, David Roy | Geschäftsführer | 20 Frensham Road GU9 8HE Farnham Surrey | England | British | 1950780001 | |||||
| GRIFFITHS OF FFORESTFACH, Brian, Lord | Geschäftsführer | 19 Chester Square SW1W 9HS London | British | 42617760001 | ||||||
| HOLT, David Leslie Frank | Geschäftsführer | 44 Osier Crescent Muswell Hill N10 1QW London | British | 100070620001 | ||||||
| LOZIER JR, James | Geschäftsführer | 3512 Crescent Avenue 75205 Dallas Texas Usa | American | 59540870001 | ||||||
| MILLMAN, Milton | Geschäftsführer | 1104 Hidden Ridge Drive 2005 Irving Texas 75038 FOREIGN Usa | American | 59779630001 | ||||||
| MURAIDEKH, Eli Sean | Geschäftsführer | Flat 2 136 Gloucester Terrace W2 6HR London | United Kingdom | British | 56166870001 | |||||
| MYERS, Martin Trevor | Geschäftsführer | Durham Place SW3 4ET London 1 | England | British | 35819830001 | |||||
| SISKIND, Edward | Geschäftsführer | 61 Ledbury Road W11 2AA London | American | 64411260001 | ||||||
| SWEENEY, Peter Charles | Geschäftsführer | The Warren 61 Leas Road CR6 9LP Warlingham Surrey | British | 30672780001 | ||||||
| WILSON, Gavin Edward Reid | Geschäftsführer | 38 Upper Cheyne Row SW3 5JJ London | British | 56166890001 |
Hat TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 19. Nov. 2009 Geliefert am 26. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the security under the charge is created in favour of the security trustee, is created over present and future assets and is security for the payment of all the secured liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 06. Mai 2004 Geliefert am 19. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intellectual property, goodwill and uncalled capital floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998 | Erstellt am 01. Apr. 1998 Geliefert am 27. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998) | |
Kurze Angaben All and whole that piece of ground extending to 468 square yards or thereby situated on the north east side of bank street in the burgh and county of inverness. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998 | Erstellt am 01. Apr. 1998 Geliefert am 27. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998) | |
Kurze Angaben All and whole that plot or area of ground at crosshill road bishopbriggs in the former parish of cawder and county of lanark which subjects form part and portion of that area of ground extending to 83.489 acres or thereby part of the lands and estate of cawder in the said former parish and county. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998 | Erstellt am 01. Apr. 1998 Geliefert am 27. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998) | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground at hattonrigg road bellshill extending to 0.65 acres or thereby imperial standard measure lying in the parish of bothwell and county of lanark. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 01. Apr. 1998 Geliefert am 14. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee under each finance document, the existing swap and any hedging agreement to which such beneficiary is a party together with all costs, charges and expenses incurred by any beneficiary in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985 (together the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0