TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED

TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03503231
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    140 London Wall
    EC2Y 5DN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PPM (PRIME) TRADING LIMITED28. Jan. 199828. Jan. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung von Ernitia Ferguson als Sekretär am 01. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Aaron Jon Burns als Sekretär am 01. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    3 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    5 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    21 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bastion House 140 London Wall London EC2Y 5DN* am 23. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Ernitia Ferguson als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Frost als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    23 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 04. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    28 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Warren Persky am 18. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURNS, Aaron Jon
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Sekretär
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    193862900001
    PERSKY, Warren Ashley
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    United KingdomBritish108635640073
    TRILLIUM GROUP LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    103653140001
    TRILLIUM HOLDINGS LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    103653930002
    BARLOW, Tracey Anne Kingsley
    25 Holmesdale Avenue
    SW14 7BQ London
    Sekretär
    25 Holmesdale Avenue
    SW14 7BQ London
    British65520910002
    BINGLEY, Joan Hilary
    Eaton Farm
    Miles Lane
    KT11 2ED Cobham
    Surrey
    Sekretär
    Eaton Farm
    Miles Lane
    KT11 2ED Cobham
    Surrey
    Irish1388610001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Sekretär
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    FERGUSON, Ernitia
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    Sekretär
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    168435690001
    FROST, William
    Bastion House 140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    Sekretär
    Bastion House 140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    British134060040001
    WILSON, Gavin Edward Reid
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    Sekretär
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    British56166890001
    BLAXLAND, Simon Thomas
    237 Rue Du Foubourg Saint Honore
    75008 Paris
    FOREIGN France
    Geschäftsführer
    237 Rue Du Foubourg Saint Honore
    75008 Paris
    FOREIGN France
    British58254750001
    CHANDE, Manish Jayantilal
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    Geschäftsführer
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    British83291490001
    ELLIS, Ian David
    Oak Lodge, Moor Road
    Great Tey
    CO6 1JJ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Oak Lodge, Moor Road
    Great Tey
    CO6 1JJ Colchester
    Essex
    EnglandBritish68191870001
    FRANCO, Jon Jacob
    Flat 10
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    Geschäftsführer
    Flat 10
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    American64630220002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    Geschäftsführer
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    EnglandBritish61183260002
    FROST, William
    Kenley Road
    SW19 3DU London
    77
    Geschäftsführer
    Kenley Road
    SW19 3DU London
    77
    British134060040001
    GARMAN, James Robert
    Flat 5
    56 Lexham Gardens
    W8 5JA London
    Geschäftsführer
    Flat 5
    56 Lexham Gardens
    W8 5JA London
    British68523620003
    GEORGI, Richard Evans
    Church Gate Hall Church Gate
    SW6 3LD London
    Geschäftsführer
    Church Gate Hall Church Gate
    SW6 3LD London
    British56166880001
    GODDEN, David Roy
    20 Frensham Road
    GU9 8HE Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    20 Frensham Road
    GU9 8HE Farnham
    Surrey
    EnglandBritish1950780001
    GRIFFITHS OF FFORESTFACH, Brian, Lord
    19 Chester Square
    SW1W 9HS London
    Geschäftsführer
    19 Chester Square
    SW1W 9HS London
    British42617760001
    HOLT, David Leslie Frank
    44 Osier Crescent
    Muswell Hill
    N10 1QW London
    Geschäftsführer
    44 Osier Crescent
    Muswell Hill
    N10 1QW London
    British100070620001
    LOZIER JR, James
    3512 Crescent Avenue
    75205 Dallas
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    3512 Crescent Avenue
    75205 Dallas
    Texas
    Usa
    American59540870001
    MILLMAN, Milton
    1104 Hidden Ridge Drive 2005
    Irving Texas 75038
    FOREIGN Usa
    Geschäftsführer
    1104 Hidden Ridge Drive 2005
    Irving Texas 75038
    FOREIGN Usa
    American59779630001
    MURAIDEKH, Eli Sean
    Flat 2 136 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    Geschäftsführer
    Flat 2 136 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    United KingdomBritish56166870001
    MYERS, Martin Trevor
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    Geschäftsführer
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    EnglandBritish35819830001
    SISKIND, Edward
    61 Ledbury Road
    W11 2AA London
    Geschäftsführer
    61 Ledbury Road
    W11 2AA London
    American64411260001
    SWEENEY, Peter Charles
    The Warren 61 Leas Road
    CR6 9LP Warlingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren 61 Leas Road
    CR6 9LP Warlingham
    Surrey
    British30672780001
    WILSON, Gavin Edward Reid
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    Geschäftsführer
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    British56166890001

    Hat TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 19. Nov. 2009
    Geliefert am 26. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 29. Dez. 2006
    Geliefert am 29. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the security under the charge is created in favour of the security trustee, is created over present and future assets and is security for the payment of all the secured liabilities.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 06. Mai 2004
    Geliefert am 19. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intellectual property, goodwill and uncalled capital floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 19. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 27. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998)
    Kurze Angaben
    All and whole that piece of ground extending to 468 square yards or thereby situated on the north east side of bank street in the burgh and county of inverness. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 27. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998)
    Kurze Angaben
    All and whole that plot or area of ground at crosshill road bishopbriggs in the former parish of cawder and county of lanark which subjects form part and portion of that area of ground extending to 83.489 acres or thereby part of the lands and estate of cawder in the said former parish and county. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 27. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998)
    Kurze Angaben
    All and whole that area of ground at hattonrigg road bellshill extending to 0.65 acres or thereby imperial standard measure lying in the parish of bothwell and county of lanark. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security document
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 14. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee under each finance document, the existing swap and any hedging agreement to which such beneficiary is a party together with all costs, charges and expenses incurred by any beneficiary in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985 (together the "secured liabilities")
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bankfor Itself and as Trustee for Each Beneficiary (As Defined Therein) (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0