THE VERVE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE VERVE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03509308
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE VERVE LIMITED?

    • Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (45200) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Einzelhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45320) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich THE VERVE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp 1 Sovereign Square
    Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE VERVE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DALMARNOCK LIMITED12. Feb. 199812. Feb. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE VERVE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Dez. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für THE VERVE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE VERVE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Mai 2016

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 28. Mai 2016

    20 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2016

    19 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 1 the Embankment Leeds LS1 4DW zum Kpmg Llp 1 Sovereign Square Sovereign Street Leeds LS1 4DA am 04. Dez. 2015

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Aug. 2015

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2015

    15 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Aug. 2014

    19 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Mai 2014

    17 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    34 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Johnston Carmichael Llp 107-111 Fleet Street London EC4A 2AB England* am 17. Dez. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 Seiten2.12B

    Änderung der Details des Direktors für Charles Patrick Adair am 27. Nov. 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Angela Margaret Colthart am 27. Nov. 2013

    2 SeitenCH03

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Dez. 2012 bis 27. Dez. 2012

    4 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 268,000
    SH01

    legacy

    7 SeitenMG01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2011

    30 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Dez. 2011 bis 28. Dez. 2011

    2 SeitenAA01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 09. Okt. 2012

    • Kapital: GBP 268,000
    5 SeitenSH01

    Wer sind die Geschäftsführer von THE VERVE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLTHART, Angela Margaret
    Dundyvan Road
    ML5 1DB Coatbridge
    19
    Lanarkshire
    Scotland
    Sekretär
    Dundyvan Road
    ML5 1DB Coatbridge
    19
    Lanarkshire
    Scotland
    British62885820003
    ADAIR, Charles Patrick
    Dundyvan Road
    ML5 1DB Coatbridge
    19
    Lanarkshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Dundyvan Road
    ML5 1DB Coatbridge
    19
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director139761810002
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector57360160001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ICETON, Ian Gordon
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    Geschäftsführer
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    BritishAccountant53359540001
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Corner Cottage
    Reynard Crag Lane
    HG3 2JQ High Birstwith
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Corner Cottage
    Reynard Crag Lane
    HG3 2JQ High Birstwith
    North Yorkshire
    BritishDirector57360160002
    WYATT, Dale
    4 Berry Close
    Hackleton
    NN7 2BS Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Berry Close
    Hackleton
    NN7 2BS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishVentures Mgr162028880001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat THE VERVE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 04. März 2013
    Geliefert am 06. März 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hyundai Capital UK Limited
    Transaktionen
    • 06. März 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2009
    Geliefert am 26. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander Consumer (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 17. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    General charge
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 19. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Volkswagen Bank Gmbh T/a Volkswagen Bank United Kingdom Branch
    Transaktionen
    • 19. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Charge
    Erstellt am 02. Feb. 2009
    Geliefert am 20. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charge provides that the chargeo shall not without the written consent of volkswagen financial services (UK) limited create or permit or suffer to come into or continue in being any charge mortgage lien pledge or other encumbrance ranking pari passu with or in priority to the charge see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 15. Apr. 2008
    Geliefert am 18. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on vehicle stocks
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 22. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all new and used motor vehicles,by way of first fixed charge all proceeds of sale, all insurance monies, all debts under the terms of any sale, all the rights title and interest in and the benefit including the right to receive rent hire charges or any other payments of all contracts, the benefit of all guarantee indemnities and securities, all debts under the terms of or in relation to the contracts, all rights enforcing the contracts and all guarantees indemnities and securities.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2007
    Geliefert am 24. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Black Horse Limited
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 9 march 2006 and
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 14. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects situated on the north west side of wildman road law t/no lan 12548.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 08. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Mortgage debenture creating a fixed and floating charge
    Erstellt am 11. Juni 2001
    Geliefert am 13. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Udt Limited
    Transaktionen
    • 13. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Bond and floating charge
    Erstellt am 14. Apr. 1999
    Geliefert am 22. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the vehicle stocking facility agreement dated 26TH november 1998 (as defined)
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 30. März 1999
    Geliefert am 09. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number A12693323L dated 8.1.99 with norwich union for the sum of £100,000 on the life of michael granville williamson together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 30. März 1999
    Geliefert am 09. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number 3731511B dated 8.1.99 with scottish provident for the sum of £250,000 on the life of charles adair together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General charge
    Erstellt am 14. Dez. 1998
    Geliefert am 17. Dez. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 1998
    Geliefert am 15. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All those monies monies which may from time to time be owing to the company by the chargee in respect of refunds of monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 21. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 19TH january 1999 and
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 21. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects on the north west side of wildman road law t/no LAN12548.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Nov. 1998
    Geliefert am 04. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as dalmarnock limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat THE VERVE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Nov. 2013Beginn der Verwaltung
    28. Mai 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Standish
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Gerard Anthony Friar
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praktiker
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praktiker
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0