JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED

JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03511197
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED?

    • (7032) /

    Wo befindet sich JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DELOITTE LLP
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    JARVIS WORKSPACE FM LIMITED12. Mai 199912. Mai 1999
    JARVIS FM LIMITED16. Feb. 199816. Feb. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2011

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 19. Sept. 2011

    18 Seiten2.35B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    25 Seiten2.17B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    9 Seiten2.39B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Athene Place 66 Shoe Lane London EC4A 3BQ am 21. Apr. 2011

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2010

    19 Seiten2.24B

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    3 SeitenMG04

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    legacy

    3 SeitenMG04

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Meridian House the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW am 09. Apr. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. März 2010

    Kapitalaufstellung am 11. März 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    21 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    21 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    KARLSEN, Kjell Konrad
    Apartment 2
    110 Duffield Road
    DE22 1BG Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Apartment 2
    110 Duffield Road
    DE22 1BG Derby
    Derbyshire
    SpainNorwegian119778420002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    JACKSON, Deborah Ann Clare
    20 Parkside Close
    Meanwood
    LS6 4LZ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    20 Parkside Close
    Meanwood
    LS6 4LZ Leeds
    West Yorkshire
    British57031290001
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British20374510001
    CUNNINGHAM, Anthony
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135811090001
    ENTWISTLE, Richard William
    Rosemead Farm
    Moor Monkton
    YO26 8JA York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Rosemead Farm
    Moor Monkton
    YO26 8JA York
    North Yorkshire
    British50174710002
    GILBERT, Ian Michael
    Parkside House Knaresborough Road
    Follifoot
    HG3 1DT Harrogate
    Geschäftsführer
    Parkside House Knaresborough Road
    Follifoot
    HG3 1DT Harrogate
    EnglandBritish54723920004
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    LAFFERTY, Henry
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    Geschäftsführer
    Windmill House
    4 High Street
    MK44 1PG Sharnbrook
    Beds
    EnglandBritish146249130001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Geschäftsführer
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritish53806830002
    SUTTON, Andrew John
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    Geschäftsführer
    Browns End Cottage
    Browns End Road
    CM6 2BE Broxted
    Essex
    United KingdomBritish110729740001
    WESTBROOK, Bernard Leslie
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish51336870001

    Hat JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 2006
    Geliefert am 08. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 09. Juni 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 13. Juli 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 09. Sept. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 25. Sept. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 08. Dez. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Dez. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Share charge
    Erstellt am 22. März 2005
    Geliefert am 06. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all its present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 03. März 2005
    Geliefert am 11. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge over all present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 11. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 11. Jan. 2005
    Geliefert am 20. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor to any secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage, all its present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 30. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage, all its present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 29. Nov. 2004
    Geliefert am 08. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or fastline to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all of the charged assets. Machine number 72203 72206 72208 72209 dynamic track stabiliser. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Network Rail Infrastructure Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 27. Aug. 2004
    Geliefert am 06. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company shall not create or permit to subsist any security over any charged asset, nor do anything else prohibited by clause 20.3 (negative pledge) of the new revolving credit facility agreement, or clause 18.3 (negative pledge) of the bond facility except as permitted by each clause.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Benefit of the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Intercreditor agreement made between (1) jarvis PLC, (2) wirral schools investment company limited, (3) jarvis construction (UK) limited, (4) jarvis workspace fm limited, (5) societe generale (the "subordinated creditors"), (6) societe generale (as "general security trustee" and as "bridge security trustee") and (7) the borrower (the "agreement").
    Erstellt am 27. März 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the senior finance liabilities due, owing, or incurred by it to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents. (All terms as defined)
    Kurze Angaben
    General undertakings until the senior finance liabilities discharge date, except with the consent of the security trustee: no payment, no set-off, no security, no other action, no amendment, no negotiable instrument, no conversion and no cancellation or transfer.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat JARVIS ACCOMMODATION SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Sept. 2011Ende der Verwaltung
    26. März 2010Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ian Brown
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0