CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD

CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03513594
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    76 King Street
    Suite 307
    M2 4NH Manchester
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    METFORCE SECURITIES LIMITED19. Feb. 199819. Feb. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Dez. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Kbs Corporate Services Limited als Sekretär am 01. Nov. 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Kbs Corporate Services Limited als Sekretär am 01. Nov. 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Kbs Corporate Services Limited als Sekretär am 01. Nov. 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Kbs Corporate Services Limited als Sekretär am 01. Nov. 2017

    1 SeitenTM02

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Barton Arcade Suite 37 Deansgate Manchester M3 2BH England zum 76 King Street Suite 307 Manchester M2 4NH am 20. Apr. 2017

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr John Lee Hickens als Direktor am 10. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2015

    3 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 31. Mai 2016

    • Kapital: GBP 100,000
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Kbs Corporate Services Limited am 29. Apr. 2016

    1 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Scala Group Ltd am 29. Apr. 2016

    1 SeitenCH02

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Elizabeth House 8a Princess Street Knutsford Cheshire WA16 6DD England zum Barton Arcade Suite 37 Deansgate Manchester M3 2BH am 12. Mai 2016

    1 SeitenAD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von John Rushton als Geschäftsführer am 13. Jan. 2015

    1 SeitenTM01

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 30. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 2
    4 SeitenSH06

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2014

    3 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HICKENS, John Lee
    King Street
    Suite 307
    M2 4NH Manchester
    76
    England
    Geschäftsführer
    King Street
    Suite 307
    M2 4NH Manchester
    76
    England
    CyprusBritish216144830001
    SCALA GROUP LTD
    Suite 37
    Deansgate
    M3 2BH Manchester
    Barton Arcade
    England
    Geschäftsführer
    Suite 37
    Deansgate
    M3 2BH Manchester
    Barton Arcade
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3115998
    78122120002
    CANON SECRETARIES LIMITED
    Market Street
    Whaley Bridge
    SK23 7AA High Peak
    Bank House
    Derbyshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Market Street
    Whaley Bridge
    SK23 7AA High Peak
    Bank House
    Derbyshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02967649
    76967210002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    KBS CORPORATE SERVICES LIMITED
    Suite 37
    Deansgate
    M3 2BH Manchester
    Barton Arcade
    England
    Sekretär
    Suite 37
    Deansgate
    M3 2BH Manchester
    Barton Arcade
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3164FN
    158263390001
    GRINDROD, Steve Thomas
    Market Street
    Whaley Bridge
    SK23 7AA High Peak
    11
    Derbyshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Market Street
    Whaley Bridge
    SK23 7AA High Peak
    11
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161417860001
    GRINDROD, Steven Thomas
    Chester House 171 Chorley New Road
    BL1 4QZ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Chester House 171 Chorley New Road
    BL1 4QZ Bolton
    Lancashire
    British77408690002
    LENTHALL, John Barry
    172 Greenbarn Way
    Blackrod
    BL6 5TF Bolton
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    172 Greenbarn Way
    Blackrod
    BL6 5TF Bolton
    Greater Manchester
    British52107560002
    RUSHTON, John
    8a Princess Street
    WA16 6DD Knutsford
    Elizabeth House
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    8a Princess Street
    WA16 6DD Knutsford
    Elizabeth House
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish11807130003
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Scala Group Ltd
    Barton Arcade
    M3 2BH Manchester
    37
    England
    12. Jan. 2017
    Barton Arcade
    M3 2BH Manchester
    37
    England
    Nein
    RechtsformCompany
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CHESTER HOUSE PROPERTY HOLDINGS LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 02. Jan. 2008
    Geliefert am 05. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property; 739A chorley old road bolton lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 2005
    Geliefert am 19. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 boden street macclesfield cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 21. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22A st georges street macclesfield cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 24. Okt. 2002
    Geliefert am 28. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the company's assets either fixed or current.
    Berechtigte Personen
    • Chester House Investments Limited
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bank house market street whaley bridge derbyshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 2001
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    8 mill road macclesfield cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 2000
    Geliefert am 01. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as 84 whitegate drive blackpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2000
    Geliefert am 06. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    12 mill road macclesfield cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 10. März 2000
    Geliefert am 28. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 8 cheltenham road chorlton manchester greatermanchester title no. GM458763. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 04. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    61 south park road macclesfeld cheshire SK11 6RF. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 2 brown street macclesfield. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 17. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property k/a 11 palmerston street bollington macclesfield cheshire SK10 5PX.t/no.CH277608.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 1998
    Geliefert am 16. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    88 stamford road birkdale southport fixed charge plant machinery fixtures fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels goodwill of any business and the proceeds of any insurance.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 07. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 04. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0