THORNFIELD PROPERTIES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHORNFIELD PROPERTIES PLC
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03516056
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THORNFIELD PROPERTIES PLC?

    • (7011) /

    Wo befindet sich THORNFIELD PROPERTIES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DELOITTE LLP
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THORNFIELD PROPERTIES PLC?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Nov. 2009
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Mai 2010
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für THORNFIELD PROPERTIES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    Seiten2.34B

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Gerichtsbeschluss

    S1096 Court Order to Rectify
    7 SeitenOC

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    9 SeitenLIQ10

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2018

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2017

    18 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2016

    16 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2015

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2014

    16 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2013

    14 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    10 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    10 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Aug. 2012

    15 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:miscellaneous - amended form 2.34B .
    1 SeitenLIQ MISC

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    18 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. März 2011

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. März 2011

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Sept. 2010

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Sept. 2010

    17 Seiten2.24B

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 14. Mai 2010

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Vorschlag des Verwalters

    23 Seiten2.17B

    Wer sind die Geschäftsführer von THORNFIELD PROPERTIES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHENERY, Richard James
    c/o Deloitte Llp
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Deloitte Llp
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United Kingdom
    148536200001
    CHENERY, Richard James
    c/o Deloitte Llp
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Deloitte Llp
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United Kingdom
    EnglandBritish146075610001
    FERGUSON, Nicholas Hugh
    c/o Deloitte Llp
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Deloitte Llp
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United Kingdom
    United KingdomBritish76088160002
    BROWN, Steven Andrew
    105 Wigmore Street
    London
    W1U 1QY
    Sekretär
    105 Wigmore Street
    London
    W1U 1QY
    British107162240001
    COLES, Andrew
    Flat 2 Eaton House
    Upper Grosvenor Street
    W1 London
    Sekretär
    Flat 2 Eaton House
    Upper Grosvenor Street
    W1 London
    British85114710001
    SHERRATT, Peter Robert
    Ark End Mallows Green Road
    Manuden
    CM23 1BP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Ark End Mallows Green Road
    Manuden
    CM23 1BP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British34368510002
    SMITH, Margaret
    19 Trinity Grove
    Bengeo
    SG14 3HB Hertford
    Hertfordshire
    Sekretär
    19 Trinity Grove
    Bengeo
    SG14 3HB Hertford
    Hertfordshire
    British74682700003
    TEMPORAL, Sarah Louise
    50 Galloway Lane
    LS28 8JR Pudsey
    West Yorkshire
    Sekretär
    50 Galloway Lane
    LS28 8JR Pudsey
    West Yorkshire
    British116974670001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BURNETT, Neil Scott
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    Geschäftsführer
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    British93937250001
    CAPOCCI, Michael Anthony Angilo
    14 Kings Avenue
    IG8 0JA Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    14 Kings Avenue
    IG8 0JA Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish33185890001
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Geschäftsführer
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish104442220001
    HARVEY, Neil
    24 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Geschäftsführer
    24 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British15272050001
    LAWRIE, Ronald Rozmus
    New Providence Wharf A501
    1 Fairmont Avenue
    E14 9PA London
    Geschäftsführer
    New Providence Wharf A501
    1 Fairmont Avenue
    E14 9PA London
    American96955160001
    LEE, Wilson Yao Chang
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    Geschäftsführer
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    American52557130001
    MARCUS, Anthony
    105 Wigmore Street
    London
    W1U 1QY
    Geschäftsführer
    105 Wigmore Street
    London
    W1U 1QY
    EnglandBritish59976230003
    MARCUS, Jason Robert
    105 Wigmore Street
    London
    W1U 1QY
    Geschäftsführer
    105 Wigmore Street
    London
    W1U 1QY
    EnglandBritish67762270010
    PETTIT, Andrew John
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    Geschäftsführer
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    British62947400001
    PORTER, Barry
    22 Dove Park
    WD3 5NY Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    22 Dove Park
    WD3 5NY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish99637030001
    PUDGE, David John
    63 Englewood Road
    SW12 9PB London
    Geschäftsführer
    63 Englewood Road
    SW12 9PB London
    British57012940001
    SANDERSON, Andrew James
    114a Church Street
    Netherthong
    HD9 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    114a Church Street
    Netherthong
    HD9 3EA Holmfirth
    West Yorkshire
    EnglandBritish50589920001
    WOOLMER, Kenneth John, Lord
    8 Ancaster Crescent
    LS16 5HS Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Ancaster Crescent
    LS16 5HS Leeds
    West Yorkshire
    UkBritish15635750001

    Hat THORNFIELD PROPERTIES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental charge
    Erstellt am 27. Jan. 2010
    Geliefert am 05. Feb. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in the additional property the insurances and all rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Nov. 2009
    Geliefert am 04. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property means land forming part of land,t/no.DY408154(other than the estate road) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • East Midlands Development Agency
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 2007
    Geliefert am 12. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at derby road chesterfield t/n's DY287347 DY286130 and DY408154,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • East Midlands Development Agency
    Transaktionen
    • 12. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land lying to the west of derby road chesterfield t/n DY287347.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2006
    Geliefert am 29. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings (being two parcels mainly the area to the north of and including the area with t/no DY337432 and secondly the area numbered 14 with t/no DY337432) and (two parcels being firstly with t/nos DY337432 and DY286130)( collectively k/a the starfish land), f/h land and buildings at lincoln works derby road chesterfield t/no DY286130. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Aug. 2006
    Geliefert am 07. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south side of barlow street, bury t/no GM146878; f/h land lying to the west side of derby street t/no GM605464 and f/h land lying to the west side of barlow street, bury t/no GM161511 (for details of further property charged please refer to from 395) by way of fixed charge all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures), its right, title and interest in and to each of the development agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 29. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being land to the north of st clair road haywards heath west sussex t/no WSX236839.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Mai 2006
    Geliefert am 01. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2006
    Geliefert am 23. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being the f/h land at ireland industrial estate fan road staveley chesterfield t/n DY2414, all property present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 19. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property being 2ND floor flat 6 st martins court dorking t/n SY630704.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 15. Juli 2005
    Geliefert am 22. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being land and buildings k/a the malthouse, mill lane, dorking t/no SY00235.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Arranger, Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Jan. 2005
    Geliefert am 21. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property meaning all sums due and owing to the company pursuant to a legal charge dated 12 january 2005 and made between (1) stagecoach south limited (2) magicbus scotland limited and (3) the company over land and buildings at high street, winchester t/no. HP569679. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2004
    Geliefert am 04. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company acting for itself and as agent and trustee for and on behalf of the lenders to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 22 mill lane dorking surrey t/no: SY528388.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    First legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 2003
    Geliefert am 10. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a kwik save premises derby street bury lancashire t/n LA365377.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Apr. 2002
    Geliefert am 27. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £84,750.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    22 mill lane dorking t/n SY528388.
    Berechtigte Personen
    • Daniel Benjamin Corby Grey and Miriam Sarah Simmons
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2002
    Geliefert am 14. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the lenders (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Deed of charge (as defined) over premises at colne road and bank parade burnley lancashire
    Erstellt am 13. Okt. 1999
    Geliefert am 22. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the transfer (and the agreement dated 27 july 1999) and to comply with all other liabilities therein
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as colne rd,burnley; t/nos LA197748 and LA746337.
    Berechtigte Personen
    • Gallaher Limited
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Feb. 1998
    Geliefert am 26. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A maximum of £2 million due or to become due from the company to the chargee as defined in the loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Any property and interest any agreements all stocks shares debentures all copyrights patents and inventions the companys interest in any insurances the benefit of any other agreements and all property assets revenues undertaking goodwill and uncalled capital present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lehman Brothers Bankhaus Ag
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat THORNFIELD PROPERTIES PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Aug. 2011Ende der Verwaltung
    10. März 2010Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Angus Matthew Martin
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Philip Stephen Bowers
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    2
    DatumTyp
    31. Aug. 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Angus Matthew Martin
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0