CARDPOINT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CARDPOINT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03516589 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARDPOINT SERVICES LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CARDPOINT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CARDTRONICS UK LIMITED Building 4, 1st Floor Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARDPOINT SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CARDPOINT SERVICES TRADING AS CASHZONE LIMITED | 19. Feb. 2009 | 19. Feb. 2009 |
| CARDPOINT SERVICES LIMITED | 23. Okt. 2008 | 23. Okt. 2008 |
| MONEYBOX CORPORATION LIMITED | 17. Jan. 2000 | 17. Jan. 2000 |
| MONEY BOX CORPORATION LIMITED | 25. Feb. 1998 | 25. Feb. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARDPOINT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CARDPOINT SERVICES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CARDPOINT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Edward Keller als Geschäftsführer am 25. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Christopher Brewster als Geschäftsführer am 25. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Edward Keller als Sekretär am 25. Juni 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Squire Sanders (Uk) Llp Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England zum C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Ernennung von Jana Hile als Direktor am 15. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy David Kraft als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham, B3 2JR am 16. Juni 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeremy David Kraft als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Michael Keller als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von John Christopher Brewster als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CARDPOINT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILE, Jana | Geschäftsführer | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | England | Australian | 192111080001 | |||||
| SIMPSON DENT, Jonathan | Geschäftsführer | Gadbrook Park CW9 7TW Northwich Davidson House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 110396210002 | |||||
| GREGSON, Robin Anthony | Sekretär | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | 107835250001 | ||||||
| HOGAN, Brenda | Sekretär | Apt 55 Sandyford View Simonsridge Blackglen Road IRISH Sandyford Dublin 18 Ireland | Other | 75975040003 | ||||||
| KATZ, Peter David | Sekretär | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
| KELLER, Michael Edward | Sekretär | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | American | 105857220002 | ||||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Sekretär | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | British | 42734310002 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ABERNETHY, Kieron Quinn | Geschäftsführer | 2 Salisbury Place West Byfleet KT14 6SN London | United Kingdom | British | 200594530001 | |||||
| BEERLING, Kevin Michael | Geschäftsführer | 14 Firside Grove DA15 8WB Sidcup Kent | United Kingdom | British | 64677850002 | |||||
| BREWSTER, John Christopher | Geschäftsführer | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | Usa | American | 181428100001 | |||||
| BROWN, Neil Graeme | Geschäftsführer | 2 Aldenham Avenue WD7 8HJ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 49772410001 | |||||
| DINSMORE, Rikki Gavin | Geschäftsführer | Aisher Way Riverhead TN13 2QS Sevenoaks 34 Kent | United Kingdom | British | 137100920001 | |||||
| EDWARDS, Mark Simon | Geschäftsführer | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | 109659860001 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Geschäftsführer | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||
| HOLROYD, Richard Norton | Geschäftsführer | Flat 8 37 De Vere Gardens W8 5AW London | British | 80220410001 | ||||||
| ISAACS, Vincent | Geschäftsführer | Denham Cottage 41 Totteridge Common Totteridge N20 8LS London | British | 38705920001 | ||||||
| KELLER, Michael Edward | Geschäftsführer | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | Usa | American | 105857220002 | |||||
| KRAFT, Jeremy David | Geschäftsführer | Avenue Gardens TW11 0BH Teddington 27 Middlesex England | United Kingdom | British | 71360190003 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Geschäftsführer | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | England | British | 42734310002 | |||||
| MALONEY, Michael John | Geschäftsführer | Beechwood Road Ranelagh 8 Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 161364970001 | |||||
| MCNAMARA, Peter Denis | Geschäftsführer | 7 B Land Avenue AL5 4RG Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 114555600001 | |||||
| MILLS, Mark Richard | Geschäftsführer | 55 Hove Road FY8 1XH Lytham St Annes Lancashire | British | 10402540005 | ||||||
| MORGAN, Colin John | Geschäftsführer | 87 Globe Wharf 205 Rotherhithe Street SE16 5XX London | Irish | 70867300001 | ||||||
| MURPHY, James Timmerman | Geschäftsführer | Park Ave #10c Nyc 1120 10728 New York Usa | American | 130237490001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Geschäftsführer | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | England | British | 116252510001 | |||||
| ROBSON, Vincent Martin | Geschäftsführer | Glebe End Station Road, Eynsford DA4 0ER Dartford Kent | British | 64602710001 | ||||||
| RYLAND, Stuart Antony | Geschäftsführer | 5 Yeading Avenue Rayners Lane HA2 9RL Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 74367340001 | |||||
| SAXTON, Paul | Geschäftsführer | 19 Ashdale Close ST7 2EN Alsager Staffordshire | British | 121726830001 | ||||||
| SMYTH, Peter Francis | Geschäftsführer | Flat 2 62 Queens Gate SW7 5JP London | Irish | 63863190002 | ||||||
| STANLEY, Paul Robert | Geschäftsführer | 70 Wolmer Gardens HA8 8DQ Edgware Middlesex | British | 58251370003 | ||||||
| STIMPSON, Andrew David | Geschäftsführer | 4 Hartswood Road W12 9NQ London | England | British | 99393670001 | |||||
| TURRELL, Mary Margaret | Geschäftsführer | 1 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | England | British | 92654710001 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat CARDPOINT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A confirmatory security agreement | Erstellt am 09. Apr. 2010 Geliefert am 13. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A second ranking share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there | Erstellt am 05. Feb. 2010 Geliefert am 22. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Existing pledges means the pledges constituted pursuant to the existing share pledge agreement, shares. The pledges include the present and future rights to receive dividends and liquidation proceeds, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 05. Dez. 2007 Geliefert am 15. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 18. Mai 2007 Geliefert am 02. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares and the future shares together with all ancillary rights and claims, dividends payable in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Syndicated debenture | Erstellt am 13. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 01. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 06. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Juli 2005 Geliefert am 15. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 2004 Geliefert am 09. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 2004 Geliefert am 03. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 03. Juni 2003 Geliefert am 21. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,100,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 52 authomated teller machines. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of chattels | Erstellt am 03. Juni 2003 Geliefert am 19. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A number of automated teller machines situated at the locations together with the benefit of a licence to retain the atms at the locations. The benefit of all contracts and agreements relating to the atms. Any goodwill in the atms. The benefit of any insurances in relating to the atms. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0