DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED

DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03517905
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o C/O BEGBIES TRAYNOR
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DUNLOP HEYWOOD LORENZ LIMITED18. Mai 200118. Mai 2001
    DUNLOP HEYWOOD & CO LIMITED08. Okt. 199808. Okt. 1998
    IBIS (419) LIMITED26. Feb. 199826. Feb. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2005

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    3 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    19 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Sekretär
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    BritishSolicitor69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishAccountant93673010002
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Geschäftsführer
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    EnglandBritishChartered Secretary11498320001
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    BritishAccountant93673010001
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant30526830004
    TSD SECRETARIES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Bevollmächtigter Sekretär
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007450001
    ALDER, Frank
    22 Menlove Gardens South
    L18 2EL Liverpool
    Geschäftsführer
    22 Menlove Gardens South
    L18 2EL Liverpool
    BritishSurveyor62975520001
    ARMITAGE, Stephen Hubert
    The Glade
    Kingswood
    KT20 6JJ Tadworth
    Briarwood
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Glade
    Kingswood
    KT20 6JJ Tadworth
    Briarwood
    Surrey
    United KingdomBritishSurveyor29773030001
    ASHWOOD, Warren Lee
    7 Pilgrim Close
    Park St.
    AL2 2JD St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    7 Pilgrim Close
    Park St.
    AL2 2JD St. Albans
    Hertfordshire
    BritishSurveyor68986060002
    BOUSFIELD, Richard John
    19 Jackson Street
    SK8 2AU Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 Jackson Street
    SK8 2AU Cheadle
    Cheshire
    BritishChartered Surveyor104442340001
    BRAY, Anthony John
    25 Chandos Road
    M21 0SS Chorlton
    Manchester
    Geschäftsführer
    25 Chandos Road
    M21 0SS Chorlton
    Manchester
    BritishSurveyor75694600001
    BROCKLEHURST, Alastair Robin
    Courtyard House
    Hobb Lane Moore
    WA4 5QS Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Courtyard House
    Hobb Lane Moore
    WA4 5QS Warrington
    Cheshire
    BritishSurveyor83971190001
    BUNTING, Ross
    5 Vaudrey Drive
    Cheadle Hulme
    SK8 5LR Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Vaudrey Drive
    Cheadle Hulme
    SK8 5LR Stockport
    Cheshire
    BritishSurveyor60887880001
    BURGESS, John
    Keys Cottage Main Street
    Bolton By Bowland
    BB7 4NW Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Keys Cottage Main Street
    Bolton By Bowland
    BB7 4NW Clitheroe
    Lancashire
    BritishSurveyor61002140001
    COOKE, Stephen Malcolm
    Lowood
    Newton In Bowland
    BB7 3DZ Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Lowood
    Newton In Bowland
    BB7 3DZ Clitheroe
    Lancashire
    BritishSurveyor59315260001
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant30526830004
    DONELLY GALLAGHER, Hugh Peter
    The Moorings 7 Barnfield Flixton
    Urmston
    M41 9EW Manchester
    Geschäftsführer
    The Moorings 7 Barnfield Flixton
    Urmston
    M41 9EW Manchester
    BritishSurveyor60887070001
    DYSON, Robert William
    14 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    Geschäftsführer
    14 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    United KingdomBritishSurveyor24554680002
    ECCLES, Christopher John Roy
    11 Montague Road
    Ealing
    W13 8HA London
    Geschäftsführer
    11 Montague Road
    Ealing
    W13 8HA London
    BritishChartered Surveyor41032220002
    FALLON, Geoffrey Trevor
    20 Askew Drive
    Spencers Wood
    RG7 1HG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    20 Askew Drive
    Spencers Wood
    RG7 1HG Reading
    Berkshire
    BritishSurveyor66085850002
    FOREMAN, Neil Richard Oates
    7 High Street
    OX49 5PZ Watlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    7 High Street
    OX49 5PZ Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritishSurveyor108536420001
    FROSHAUG, Christopher Alan
    12 Saint Catherines Road
    RH10 3TA Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    12 Saint Catherines Road
    RH10 3TA Crawley
    West Sussex
    BritishDirector76571190001
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Geschäftsführer
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritishChartered Surveyor16684130002
    GORDON, Richard John
    44 Westgate
    Hale
    WA15 9AZ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    44 Westgate
    Hale
    WA15 9AZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishSurveyor41159660001
    HORDER, Jane
    Flat 3 36 Elsworthy Road
    NW3 3DL London
    Geschäftsführer
    Flat 3 36 Elsworthy Road
    NW3 3DL London
    EnglandEnglishSurveyor60268720001
    JAMES, Simon Nicholas
    The Old Vicarage
    24 Darley Avenue
    M20 2YD Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    24 Darley Avenue
    M20 2YD Manchester
    Lancashire
    BritishSurveyor65239760001
    JONES, Philip Neil
    122 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    122 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Surveyor33922130002
    KAHN, David Philip
    1 Gurney Drive
    East Finchley
    N2 0DF London
    Geschäftsführer
    1 Gurney Drive
    East Finchley
    N2 0DF London
    BritishEstate Agent54880020001
    KING, Michael Augustine
    2 Kingsley Avenue
    SK9 4EN Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    2 Kingsley Avenue
    SK9 4EN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSurveyor47445430001
    LEGGETT, Graeme Barrie
    17 Suffolk Drive
    Weybrook Park
    GU4 7FD Burpham Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Suffolk Drive
    Weybrook Park
    GU4 7FD Burpham Guildford
    Surrey
    BritishSurveyor73722600001
    LIDGLEY, Paul Philip
    Station House
    Old Burghclere
    RG20 9NT Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Station House
    Old Burghclere
    RG20 9NT Newbury
    Berkshire
    BritishSurveyor60886850001
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    Geschäftsführer
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritishDirector62622410007
    LORENZ, Anthony Michael
    Flat 1 12-14 Reeves Mews
    W1K 2EG London
    Geschäftsführer
    Flat 1 12-14 Reeves Mews
    W1K 2EG London
    EnglandBritishEstate Agent76126010002
    MCGARRY, Ian Mark
    10 Nomansland
    AL4 8EJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    10 Nomansland
    AL4 8EJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor96614800001
    MILLAR MILLS, John Anthony
    8 Knutsford Road
    SK9 6JA Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    8 Knutsford Road
    SK9 6JA Wilmslow
    Cheshire
    BritishFinance Director49333640001

    Hat DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 20. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned rights and benefits being the rights and benefits of the assignors under the policy including (without limitation) those arising out of the judgment and the settlement agreement all and any rights and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of indemnity and charge
    Erstellt am 06. Juli 2007
    Geliefert am 17. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the company's interest in the claims, causes of action and rights of the company in relation to (a) claims for damages against the brokers of the primary professional indemnity insurance cover and excess professional indemnity insurance cover (the "cover") and (b) claims for an indemnity against the underwriters of the cover (together the "broker claims"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Erinaceous Group PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2004
    Geliefert am 24. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 06. März 2002
    Geliefert am 14. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 14. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 09. Nov. 1999
    Geliefert am 19. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company (as therein defined) to the chargee whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    340 gray's inn road london WC1X 8BJ t/n NGL107046. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. März 2015Abschluss der Liquidation
    23. Jan. 2008Antragsdatum
    12. Mai 2008Beginn der Liquidation
    23. Juni 2015Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Paul Stanley
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Praktiker
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0