WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03518803 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
- Förderung von Erdöl (06100) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Wo befindet sich WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One St Peter's Square M2 3DE Manchester United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ENDEAVOUR NORTH SEA LIMITED | 21. Nov. 2006 | 21. Nov. 2006 |
TALISMAN EXPRO LIMITED | 19. Dez. 2005 | 19. Dez. 2005 |
PALADIN EXPRO LIMITED | 13. Jan. 2000 | 13. Jan. 2000 |
PALADIN RESOURCES (BITTERN) LIMITED | 02. Sept. 1998 | 02. Sept. 1998 |
LUDGATE 162 LIMITED | 27. Feb. 1998 | 27. Feb. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2019 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2020 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 27. Feb. 2021 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 10. Apr. 2021 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 27. Feb. 2020 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr Matthew Mulcahy als Direktor am 15. Mai 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati als Geschäftsführer am 15. Mai 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Erik Brodahl als Geschäftsführer am 15. Mai 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Bard Skabo als Geschäftsführer am 15. Mai 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jon Bard Skabo am 03. Apr. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Erik Brodahl am 03. Apr. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Change of details for Waldorf Production Uk Limited as a person with significant control on 12. Apr. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Ernennung von Jon Bard Skabo als Direktor am 24. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Martyn Roger Tanner als Direktor am 24. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Erik Brodahl als Direktor am 24. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Bard Skabo als Geschäftsführer am 29. Jan. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Erik Brodahl als Geschäftsführer am 29. Jan. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Mr Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati zum Geschäftsführer | 3 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Feb. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Endeavour Energy Uk Limited as a person with significant control on 29. Nov. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Erik Brodahl als Direktor am 22. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati als Direktor am 22. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Jon Bard Skabo als Direktor am 22. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine L. Stubbs als Geschäftsführer am 22. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Vinson & Elkins Rllp 24th Floor 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY England zum One St Peter's Square Manchester M2 3DE am 19. Nov. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULCAHY, Matthew | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | Scotland | English | Technical Director | 206522020001 | ||||
TANNER, Paul Martyn Roger | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | United Kingdom | British | Lawyer | 287235120001 | ||||
CRAW, Jaquelynn Forsyth | Sekretär | 54 Beaconsfield Place AB15 4AJ Aberdeen Aberdeenshire | British | Legal Manager | 109665360001 | |||||
ELLAM, Robert James | Sekretär | Sycamore House Rectory Road Hampton Bishop HR1 4JU Hereford Herefordshire | British | 59115350001 | ||||||
PAGANIS, Karen | Sekretär | 6426 Eaglewood Green Lane Spring Harris Tx 77379 Usa | British | 126751310001 | ||||||
POWELL, Sally Caroline | Sekretär | Park Farm Barn Church Lane WR2 6PF Hallow Worcestershire | British | 73499120003 | ||||||
TEAGUE, Don | Sekretär | 2200 Willowick \ 16d Houston Texas 77027 Usa | American | Executive | 116981530001 | |||||
LUDGATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7 Pilgrim Street EC4V 6DR London | 900013900001 | |||||||
BRODAHL, Erik | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | Norway | Norwegian | Company Director | 259915260001 | ||||
BRODAHL, Erik | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | Norway | Norwegian | Director | 289176780001 | ||||
BUCKEE, James William | Geschäftsführer | 240/40th Avenue Sw Calgary Alberta T2s 0x3 Canada | British | Executive | 46195090001 | |||||
CHINTALAPATI, Venkata Vardhana Aaditya | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 242565870001 | ||||
CRAW, Jaquelynn Forsyth | Geschäftsführer | 54 Beaconsfield Place AB15 4AJ Aberdeen Aberdeenshire | British | Legal Manager | 109665360001 | |||||
DAVISON, Paul | Geschäftsführer | Selwood Rickford Worplesdon GU3 3PJ Guildford Surrey | British | Director | 59343700002 | |||||
FITZPATRICK, Robert Francis Trew | Geschäftsführer | Broad Hinton House Broad Hinton SN4 9PA Swindon Wiltshire | England | British | Director Uk Business | 95621990001 | ||||
FRANKLIN, Roy Alexander | Geschäftsführer | Culmer Farm House Petworth Road,Wormley GU8 5SW Godalming Surrey | British | Director | 5667230002 | |||||
GRENZ, Carl | Geschäftsführer | One Ropemaker Street EC2Y 9UE London Citypoint 33rd Floor | Uk | British | None | 146425220001 | ||||
GRIFFITHS, David | Geschäftsführer | Merrydawns Meadowside KT23 3LG Great Bookham Surrey | British | Geophysicist | 115393840001 | |||||
MCDOWELL, Cuthbert John | Geschäftsführer | Down Street W1J 7AJ London 7 | United Kingdom | British | Director | 54783520001 | ||||
MITHEN, David Patrick | Geschäftsführer | Carpe Diem House Daviot AB51 0HZ Inverurie Aberdeenshire | British | Manager | 60585460001 | |||||
MUNNS, James William | Geschäftsführer | 31 Chantry Hurst KT18 7BW Epsom Surrey | England | British | Exploration Director | 96456540001 | ||||
POWELL, Sally Caroline | Geschäftsführer | Park Farm Barn Church Lane WR2 6PF Hallow Worcestershire | Uk | British | Solicitor | 73499120003 | ||||
REID, Colin John Watson | Geschäftsführer | 6 Moray Place AB15 4AF Aberdeen | Scotland | British | Petroleum Engineer | 87210540002 | ||||
SHEPPARD, Mary Jacqueline | Geschäftsführer | 1316 Prospect Avenue Sw Calgary T2T OX5 Alberta Canada | Canadian | Executive | 47103050001 | |||||
SKABO, Jon Bard | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | Norway | Norwegian | Company Director | 304275580001 | ||||
SKABO, Jon Bard | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | Norway | Norwegian | Director | 289179680001 | ||||
STUBBS, Catherine L. | Geschäftsführer | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | United States | American | Director | 167197320001 | ||||
WALKER, Nicholas John Robert | Geschäftsführer | 3 Kepplestone Gardens AB15 4DH Aberdeen | British | Manager | 109709500001 | |||||
LUDGATE NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Pilgrim Street EC4V 6DR London | 900013890001 | |||||||
LUDGATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Pilgrim Street EC4V 6DR London | 900013900001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldorf Production Uk Plc | 30. Juni 2016 | St Peter's Square M2 3DE Manchester One England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 22. Okt. 2019 Geliefert am 24. Okt. 2019 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 08. Feb. 2010 Geliefert am 16. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other grantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All equipment, all inventory, all accounts, the initial pledged equity, all additional shares of stock, all indebtedness the securites accounts, the account collateral, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Feb. 2010 Geliefert am 15. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including the relevant project accounts, any present or future insurances together with all related property rights, the hedging agreements, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Nov. 2006 Geliefert am 10. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the all property and assets present and future including the relevant project accounts, insurances, and the hedging agreements,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement | Erstellt am 01. Nov. 2006 Geliefert am 13. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in all equipment, all inventory, all accounts, the initial pledged equity, all additional shares, all indebtedness, all contracts, the account collateral, intellectual property collateral,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus letter of set-off | Erstellt am 28. März 2006 Geliefert am 31. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 30. Juli 2004 Geliefert am 10. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all of its rights to and title and interest from time to time in the whole of its property (including, for the avoidance of doubt, any insurance proceeds), assets, rights and revenues, whatsoever and wheresoever, present and future, including its uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 25. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor or any obligor to the agent and the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 21. Aug. 2002 Geliefert am 27. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and discharge all obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the chargee as agent and trustee for itself, the other finance parties and the overdraft bank (the "agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The whole of its property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 18. Dez. 2000 Geliefert am 04. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and discharge all obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) or to the overdraft bank under or pursuant to the finance documents (or any of them) or the overdraft (all as defined therein) | |
Kurze Angaben All of its right title and interest in the whole of its property, assets, rights and revenues including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0