BOXBROOK HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BOXBROOK HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03526170 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BOXBROOK HOLDINGS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BOXBROOK HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BOXBROOK HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BOXBROOK HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT zum C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 27. Apr. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 23. Sept. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Birchwood Group Holdings Limited as a person with significant control on 25. Sept. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Grimason als Geschäftsführer am 06. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Deborah Grimason am 13. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BOXBROOK HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| ALLEN, Timothy Peter | Sekretär | Barton Park House Ashbourne Road DE65 5AT Church Broughton Derbyshire | British | 92777740001 | ||||||||||
| BALL, Ute Suse | Sekretär | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | British | 118371550001 | ||||||||||
| BOLLU, Pierre | Sekretär | 20 Lime Grove Avenue NG9 4AR Chilwell Nottinghamshire | British | 92317380001 | ||||||||||
| BOLLU, Pierre | Sekretär | 20 Lime Grove Avenue NG9 4AR Chilwell Nottinghamshire | British | 92317380001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | 158166570001 | |||||||||||
| SMITH, Anthony Edward | Sekretär | 278 Heanor Road DE7 8TG Ilkeston Derbyshire | British | 36984820003 | ||||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House | England | British | 185755960002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| MURRAY, John Roderick | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | United Kingdom | British | 145111310001 | |||||||||
| SIMONS, John Barry | Geschäftsführer | 28 Bromyard Terrace St Johns WR2 5BW Worcester Worcestershire | United Kingdom | British | 94492900001 | |||||||||
| SLARK, Gavin | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | United Kingdom | British | 162972090001 | |||||||||
| SMITH, Anthony Edward | Geschäftsführer | Bonita House 11 Risborrow Close DE65 6HY Etwall Derbyshire | United Kingdom | British | 36984820004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BOXBROOK HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp Shelfco No.2 Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BOXBROOK HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 11. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 13. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property of the chargor situate in england and wales and all liens, charges, options, agreements, rights and interests in or over land or the proceeds of sale of land and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property or land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 11. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BOXBROOK HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0