ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03528049 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen n.n.a. (63990) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Broadgate EC2M 2QS London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Roger Haworth als Geschäftsführer am 14. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Giles Harvey Roberts Richardson als Direktor am 16. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keir Murray Fawcus als Geschäftsführer am 27. Jan. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Low als Geschäftsführer am 30. Apr. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lacey als Geschäftsführer am 06. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lacey als Sekretär am 06. Juni 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Roger Haworth als Direktor am 12. Jan. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Wpp Group (Nominees) Limited als Sekretär am 12. Jan. 2015 | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2014 bis 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Farm Street W1J 5RJ London 27 England |
| 80143770001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Giles Harvey Roberts | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 224284590001 | |||||||||
| GULLIVER, John Keith | Sekretär | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | British | 147777590001 | ||||||||||
| LACEY, Stephen | Sekretär | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | 167695820001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Sekretär | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | 148710950001 | |||||||||||
| MELVILLE, George Alexander Easson | Sekretär | 77 Brampton Road AL1 4QA St. Albans Hertfordshire | British | 70332790001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Sekretär | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | British | 141063520001 | ||||||||||
| WAIT, Sarah Catherine | Sekretär | 2 Brackendale Gloucester Road KT1 3RL Kingston Upon Thames Surrey | British | 34628940002 | ||||||||||
| WEBBER, Linda | Sekretär | 123 Ellerton Road KT6 7UA Surbiton Surrey | British | 76795590003 | ||||||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||||||
| BEYTS, Timothy Charles | Geschäftsführer | 92 Louisville Road SW17 8RU London | British | 11765410002 | ||||||||||
| FAWCUS, Keir Murray | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 84594470003 | |||||||||
| GULLIVER, John Keith | Geschäftsführer | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | United Kingdom | British | 147777590001 | |||||||||
| HALL, David John | Geschäftsführer | 4 Portobello Studios 5 Haydens Place W11 1LY London | England | British | 97017290003 | |||||||||
| HARKNESS, Peter Martin | Geschäftsführer | 19 Horsley Court Montaigne Close Regency Street SW1 4BF London | United Kingdom | British | 146757430001 | |||||||||
| HAWORTH, John Roger | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 91354480002 | |||||||||
| HOOPER, John Hamilton | Geschäftsführer | Silvertrees Wilderness Road BR7 5EY Chislehurst Kent | British | 52456790002 | ||||||||||
| LACEY, Stephen | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 88368490002 | |||||||||
| LOW, Peter | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 65476890002 | |||||||||
| OWEN, Michael William Anthony | Geschäftsführer | Burg Stavenow Stavenow FOREIGN Germany 19357 | British | 71933480004 | ||||||||||
| SILLETT, Andrew | Geschäftsführer | 2 Brackendale Gloucester Road KT1 3RL Kingston Upon Thames Surrey | England | British | 50213480002 | |||||||||
| SOOKE, Thomas Peter | Geschäftsführer | 4 Monmouth Road W2 5SB London | British | 19451990001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Geschäftsführer | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | England | British | 141063520001 | |||||||||
| TIMSON, Evelyn Ruth | Geschäftsführer | Garden Hill Guildford Road, Westcott RH4 3NJ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 115799140002 | |||||||||
| WAIT, Sarah Catherine | Geschäftsführer | 2 Brackendale Gloucester Road KT1 3RL Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 34628940002 | |||||||||
| WEBBER, Linda | Geschäftsführer | 123 Ellerton Road KT6 7UA Surbiton Surrey | England | British | 76795590003 | |||||||||
| WILSON, Robert | Geschäftsführer | 8 Bywater Road South Woodham Ferrers CM3 7AJ Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 81972040001 | |||||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precise Media Group Holdings Limited | 01. März 2017 | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Erstellt am 14. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property all licences all computers vehicles office equipment and other equipment the benefit of all contracts licences and warranties the charged securities the cash collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 23. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £135,000 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all the property and undertaking of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 2004 Geliefert am 08. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Jan. 2002 Geliefert am 06. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee up to £269,000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0