WELDONVALE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWELDONVALE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03530642
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WELDONVALE LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich WELDONVALE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Quadrant House, Floor 6
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WELDONVALE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für WELDONVALE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 01. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Alan Pearlman am 01. Apr. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    10 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Alan Pearlman am 17. Apr. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Howard Alan Pearlman am 17. Apr. 2015

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. März 2015

    Kapitalaufstellung am 31. März 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 24. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Howard Alan Pearlman als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Patrick Colvin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Patrick Colvin als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Robert Goldberger am 15. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von WELDONVALE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PEARLMAN, Howard Alan
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    Sekretär
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    British154411300001
    GOLDBERGER, Michael Robert
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    United KingdomBritish77295560002
    PEARLMAN, David Alan
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    Geschäftsführer
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United KingdomBritish35550120001
    COLVIN, Patrick
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    Sekretär
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    British5954030001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    COLVIN, Patrick
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    Geschäftsführer
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    EnglandBritish5954030001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat WELDONVALE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge deed
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 10. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged units. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 10. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 30, 32 and 34 langham street london t/nos 33203 and 246597. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 10. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 30. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or structadene limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 136-142 great portland street, 109-110 bolsover street and 91 cavendish street london t/nos NGL94507 and NGL94508 all buildings and fixtures and all plant machinery vehicles computers and office and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 30. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or structadene limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged units being all units in the unit trust the mortgages pledges charges. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of amendment
    Erstellt am 23. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Charged property and real property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 1999
    Geliefert am 01. Okt. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or structadene limited to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture or the loan agreement constituted by the company's acceptance on 26 july 1999 of the lenders facility letter dated 20 july 1999 (the "loan agreement") and other finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 30 and 32 langham street in the city of westminster t/n 333203 and 34 langham street in the city of westminster t/n 246597. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 08. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 08. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 95 great portland street and 30/34 langham street london t/nos: 246597 and 333203 floating charge over all property and assets of whatsoever now or in the future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 31. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due under a guarantee of even date and other sums pursuant to the security documents
    Kurze Angaben
    Floating charge over the company's undertaking property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 31. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 31. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due under a guarantee of even date and other sums pursuant to the security documents
    Kurze Angaben
    All that l/h land being 30 and 32 langham street in the city of westminster.t/no.333203.all that l/h land being 95 great portland street and 34 langham street in the city of westminster.t/no.246597.together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery now or hereafter thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 31. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0