WELDONVALE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WELDONVALE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03530642 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WELDONVALE LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich WELDONVALE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WELDONVALE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WELDONVALE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Alan Pearlman am 01. Apr. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Alan Pearlman am 17. Apr. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Howard Alan Pearlman am 17. Apr. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Howard Alan Pearlman als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Colvin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Colvin als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Robert Goldberger am 15. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WELDONVALE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARLMAN, Howard Alan | Sekretär | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | British | 154411300001 | ||||||
| GOLDBERGER, Michael Robert | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 77295560002 | |||||
| PEARLMAN, David Alan | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | British | 35550120001 | |||||
| COLVIN, Patrick | Sekretär | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | British | 5954030001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| COLVIN, Patrick | Geschäftsführer | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | England | British | 5954030001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat WELDONVALE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge deed | Erstellt am 30. Juli 2007 Geliefert am 10. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged units. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 2007 Geliefert am 10. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 30, 32 and 34 langham street london t/nos 33203 and 246597. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2007 Geliefert am 10. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 21. März 2006 Geliefert am 30. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and or structadene limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H 136-142 great portland street, 109-110 bolsover street and 91 cavendish street london t/nos NGL94507 and NGL94508 all buildings and fixtures and all plant machinery vehicles computers and office and other equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 21. März 2006 Geliefert am 30. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and or structadene limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged units being all units in the unit trust the mortgages pledges charges. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Charged property and real property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 1999 Geliefert am 01. Okt. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or structadene limited to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture or the loan agreement constituted by the company's acceptance on 26 july 1999 of the lenders facility letter dated 20 july 1999 (the "loan agreement") and other finance document (as defined) | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 30 and 32 langham street in the city of westminster t/n 333203 and 34 langham street in the city of westminster t/n 246597. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 08. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 08. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 95 great portland street and 30/34 langham street london t/nos: 246597 and 333203 floating charge over all property and assets of whatsoever now or in the future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 31. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due under a guarantee of even date and other sums pursuant to the security documents | |
Kurze Angaben Floating charge over the company's undertaking property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 31. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due under a guarantee of even date and other sums pursuant to the security documents | |
Kurze Angaben All that l/h land being 30 and 32 langham street in the city of westminster.t/no.333203.all that l/h land being 95 great portland street and 34 langham street in the city of westminster.t/no.246597.together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery now or hereafter thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0