PIM TRUSTEES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePIM TRUSTEES LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03531478
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PIM TRUSTEES LIMITED?

    • Andere berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten n.a. (74909) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PIM TRUSTEES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    FRP ADVISORY TRADING LIMITED
    Jupiter House Warley Hill Business Park The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PIM TRUSTEES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVERS TRUSTEES LTD.18. Dez. 200118. Dez. 2001
    PIMCO TRUSTEES LIMITED20. März 199820. März 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIM TRUSTEES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2023
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2023
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2022

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PIM TRUSTEES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis20. März 2024
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung03. Apr. 2024
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis20. März 2023
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für PIM TRUSTEES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    25 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    28 SeitenWU07

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Room 14 Redhill Aerodrome Business Centre Kings Mill Lane Redhill Surrey RH1 5JZ England zum Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE am 03. Jan. 2024

    2 SeitenAD01

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Room 14 Redhill Aerodrome Business Centre Redhill Aerodrome Kings Mill Lane Redhill RH1 5JY England zum Room 14 Redhill Aerodrome Business Centre Kings Mill Lane Redhill Surrey RH1 5JZ am 25. Apr. 2023

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2022

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Old Tannery Secretaries am 09. Nov. 2022

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Old Tannery Oakdene Road Redhill Surrey RH1 6BT zum Room 14 Redhill Aerodrome Business Centre Redhill Aerodrome Kings Mill Lane Redhill RH1 5JY am 29. Nov. 2022

    1 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2021

    7 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 035314780026 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2020

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018

    10 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von PIM TRUSTEES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OLD TANNERY SECRETARIES
    Redhill Aerodrome
    Kings Mill Lane
    RH1 5JY Redhill
    Room 14 Redhill Aerodrome Business Centre
    England
    Sekretär
    Redhill Aerodrome
    Kings Mill Lane
    RH1 5JY Redhill
    Room 14 Redhill Aerodrome Business Centre
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer10467540
    218580490001
    WOOLLEY, Michael John
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Geschäftsführer
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish70967640003
    ARMSTRONG, Christine Carole
    13 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    Sekretär
    13 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    British65371850001
    BEW, Jane Elizabeth
    22 Devon Road
    RH1 3EU Redhill
    Surrey
    Sekretär
    22 Devon Road
    RH1 3EU Redhill
    Surrey
    British92579430001
    BEW, Jane Elizabeth
    22 Devon Road
    RH1 3EU Redhill
    Surrey
    Sekretär
    22 Devon Road
    RH1 3EU Redhill
    Surrey
    British92579430001
    LEONG, Susan
    8 Dominion Road
    CR0 6JP Croydon
    Surrey
    Sekretär
    8 Dominion Road
    CR0 6JP Croydon
    Surrey
    British64462020001
    LLOYD, Mary Ann
    Tudor House Chipstead Lane
    Kingsworth
    KT20 6RH Tadworth
    Surrey
    Sekretär
    Tudor House Chipstead Lane
    Kingsworth
    KT20 6RH Tadworth
    Surrey
    British58200920002
    WALKER, Jill Catherine
    7 Birkheads Road
    RH2 0AR Reigate
    Surrey
    Sekretär
    7 Birkheads Road
    RH2 0AR Reigate
    Surrey
    British41276140002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    JJ COMPANY SECRETARIAT LIMITED
    Wellingtonia Place
    Reigate Hill
    RH2 9NG Reigate
    6
    Surrey
    England
    Sekretär
    Wellingtonia Place
    Reigate Hill
    RH2 9NG Reigate
    6
    Surrey
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2086492
    75739830002
    IMRIE, Eileen Margaret
    161 Wordsworth Mead
    RH1 1AL Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    161 Wordsworth Mead
    RH1 1AL Redhill
    Surrey
    British36837650001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PIM TRUSTEES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Michael John Woolley
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    06. Apr. 2016
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

    Hat PIM TRUSTEES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 10. Feb. 2017
    Geliefert am 16. Feb. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land on the south west side of brook chatham t/no K498804.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Feb. 2017
    Geliefert am 16. Feb. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    F/H property k/a watmough house the parade wrotham road meopham gravesend t/no K84559.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Feb. 2017
    Geliefert am 16. Feb. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    L/H property k/a ground floor premises 357-365 lordship lane london t/no TGL319575.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Feb. 2017
    Geliefert am 16. Feb. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land lying to the west of upper wickham lane welling t/no SGL736543.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Dez. 2013
    Geliefert am 18. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    L/H unit 8 priory house cloisters buiness centre 8 battersea park road london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Sept. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2012
    Geliefert am 05. Dez. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee
    Kurze Angaben
    Ground floor, 357-365 lordship lane, dulwich, london t/no TGL319575.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2011
    Geliefert am 30. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Office suite b flag house 47 brunswick court london t/no TGL241521 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Iden croft herbs frittenden road staplehurst kent t/no K941438 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The barn iden croft staplehurst kent t/no K946551 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Mai 2008
    Geliefert am 03. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the west side of wigley bush lane south weald brentwood t/no EX803878; by way of specific charge, the goodwill & connection of the business or businesses & also by way of a floating security, all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work in progress & other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party legal charge
    Erstellt am 20. Juni 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the trustees from time to time of inside out trust and/or colin john pennington and christopher john parker (the trust) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    225 victoria park road london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from time to time of inside out trust (the trust) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground floor of laser house laser lane otherwise k/a 26A kings road st leonards on sea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 2007
    Geliefert am 10. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The butterfly & wildlife park little london lincolnshire t/no LN262242. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 21. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 4 and 4A baker street weybridge t/no SY728275. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 27. Okt. 2006
    Geliefert am 09. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the trustees from time to time of the fisher land limited retirements benefits scheme to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 4 saxon court marefair northampton,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party legal charge
    Erstellt am 27. Okt. 2006
    Geliefert am 08. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the trustees from time to time of the fisher land limited retirements benefits scheme to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    190 fulham palace road fulham london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Juli 2006
    Geliefert am 01. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 6 colthrop business park colthrop lane colthrop thatcham t/no BK379868. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2006
    Geliefert am 21. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H unit 2 459 southchurch road southend. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2005
    Geliefert am 16. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £250,000.00 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    White horse inn mill green edwardstone sudbury suffolk t/n SK123062.
    Berechtigte Personen
    • Norton Organic Grain Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Dez. 2005
    Geliefert am 07. Jan. 2006
    Ausstehend
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 12. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 6 and 8 cherrydown aven. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2004
    Geliefert am 15. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1 castlefield road reigate surrey t/no SY265012 with all building trade and other fixtures,fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due (but limited to the extent of the assets of pim trustees limited as trustees of the coudy bay ssas) from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Unit 13 block 4 horizon business village 1 brooklands road weybridge surrey. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 03. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property being 102/104 prince of wales road norwich norfolk t/no NK64183 & UNIT18 gibcracks barstable west basildon ess. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 03. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold property known as and being valentine house 18-20 pembroke business centre gardiners lane south basildon essex t/n EX427259.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat PIM TRUSTEES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Aug. 2023Antragsdatum
    29. Nov. 2023Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Praktiker
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Paul Atkinson
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praktiker
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Nedim Patrick Ailyan
    Frpadvisory Trading Limited Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praktiker
    Frpadvisory Trading Limited Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0