BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED

BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03540803
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    • Tätigkeit von Holdinggesellschaften für die Produktion (64202) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BEALAW (464) LIMITED03. Apr. 199803. Apr. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2016

    8 Seiten4.68

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Holland Place Wardentree Park Pinchbeck Spalding PE11 3ZN verlegt

    2 SeitenAD03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:block transfer court order - replacement of liquidator
    16 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Britton Taco Ltd Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd England zum Holland Place Wardentree Park Pinchbeck Spalding PE11 3ZN geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Britton Taco Ltd Road One Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd zum 1 More London Place London SE1 2AF am 26. Okt. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Sept. 2015

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Erfüllung der Belastung 035408030008 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Mark Edward Lapping als Geschäftsführer am 31. Aug. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Juli 2015

    • Kapital: GBP 37,121,708
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Lee Richardson als Sekretär am 30. Juni 2014

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Lee David Richardson als Geschäftsführer am 30. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Karl Robert Bostock als Sekretär am 01. Juli 2014

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    2 SeitenAA

    Ernennung von Mr Mark Edward Lapping als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Karl Bostock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Darren Dean als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 37,121,708
    SH01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 035408030008

    95 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOSTOCK, Karl Robert
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Sekretär
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    199030580001
    BOSTOCK, Karl Robert
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Geschäftsführer
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritish188188900001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Sekretär
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    British94622690001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Sekretär
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    British42598360003
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    British78877930001
    RICHARDSON, Lee
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    Sekretär
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    British177380860001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Sekretär
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    British73033280001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002710001
    CLARK, Michael
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    EnglandBritish92294570002
    DEAN, Darren William
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish114199420001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritish42598360003
    HART, Raymond John
    Witches Broom Raggleswood
    BR7 5NH Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Witches Broom Raggleswood
    BR7 5NH Chislehurst
    Kent
    British63042500002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    UkBritish78877930001
    LAPPING, Mark Edward
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Geschäftsführer
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritish188189180001
    LUCAS, Robert Richard
    AL6
    Geschäftsführer
    AL6
    British70329570002
    MILLICAN, Keith
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    Geschäftsführer
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    British59839640001
    RICHARDSON, Lee David
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    WalesWelsh217305230001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Geschäftsführer
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    EnglandBritish73033280001
    SINGER, Ronald
    9 Glen Avon Drive Riverside
    Connecticut 06878
    Usa
    Geschäftsführer
    9 Glen Avon Drive Riverside
    Connecticut 06878
    Usa
    American70787590001
    SMITH, Colin Alfred
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    Geschäftsführer
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    EnglandBritish66857520002
    TURNER, Barry John
    Bridge House
    Newby Wiske
    DL7 9EX Northallerton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bridge House
    Newby Wiske
    DL7 9EX Northallerton
    North Yorkshire
    EnglandBritish178909830001
    WARD, Justin Paul
    Flat 11 6 Oakhill Road
    SW15 2QU London
    Geschäftsführer
    Flat 11 6 Oakhill Road
    SW15 2QU London
    British78777110001
    WATSON, Alexander Ernest
    Ridgemead
    Mill Lane
    HP8 4NR Chalfont-St-Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Ridgemead
    Mill Lane
    HP8 4NR Chalfont-St-Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish18239870001
    WATTERS, Roderick Ian Alistair
    The Mill
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Mill
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Australian67175860001
    CROFT NOMINEES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002700001

    Hat BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Nov. 2013
    Geliefert am 15. Nov. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Bank Usa as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Juni 2011
    Geliefert am 08. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 31. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest the excluded proceeds the relevant contracts the insurances the charged accounts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transaktionen
    • 31. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2008
    Geliefert am 13. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Michael Clark, as Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2008
    Geliefert am 05. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including buildings fixtures fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank Holdings PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2008
    Geliefert am 01. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transaktionen
    • 01. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 2004
    Geliefert am 27. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the holders of the ever 2284 limited variable rate loan notes 2013 (the noteholders) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 27. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 2004
    Geliefert am 27. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BRITTON GROUP (HOLDINGS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Sept. 2015Beginn der Liquidation
    02. Juni 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Russell Payne
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0