WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY

WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 03543429
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    27 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLACKSTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY03. Apr. 199803. Apr. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    16 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 15. Juli 2022

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy David Cape am 22. Nov. 2021

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    17 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy David Cape am 05. Aug. 2021

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    12 SeitenMA

    Ernennung von Mr Jeremy David Cape als Direktor am 25. Feb. 2021

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Nasir Pasha als Direktor am 25. Feb. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mahmoud Raafat als Geschäftsführer am 25. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Liam Cunningham als Geschäftsführer am 25. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    21 SeitenAA

    Change of details for Raglan Real Estate Acquisition Company as a person with significant control on 01. Aug. 2019

    5 SeitenPSC05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Maybourne Hotel Group 41-43 Brook Street Mayfair London W1K 4HJ England zum 27 Knightsbridge London SW1X 7LY am 01. Aug. 2019

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAPE, Jeremy David
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish,Argentine280421610001
    PASHA, Nasir
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish280348180001
    SOCKER, Marc Nathan
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    United KingdomBritish253588970001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Sekretär
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Irish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Sekretär
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    British108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Sekretär
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Sekretär
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Sekretär
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    British74719200002
    GRAY, Jonathan David
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Sekretär
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Usa65836770001
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Sekretär
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    British138522860001
    ALDEN, Stephen Jude
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    Mayfair
    W1J 0AH London
    1
    England
    Geschäftsführer
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    Mayfair
    W1J 0AH London
    1
    England
    United KingdomMaltese115411150008
    ALLEN, David Weston
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Irish99989350001
    BAKHOS, Fady
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Geschäftsführer
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    QatarFrench206158260001
    BARRACK JR, Thomas Joseph
    PO BOX 358
    Santa Ynez
    California 93460
    Usa
    Geschäftsführer
    PO BOX 358
    Santa Ynez
    California 93460
    Usa
    American58370240001
    CERIALE, John Victor
    13 Prospect Road
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Geschäftsführer
    13 Prospect Road
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Usa65836740001
    CUNNINGHAM, Liam
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    IrelandIrish198255770001
    DONNELLY, Peter Joseph
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish93945650001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    United KingdomIrish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    United KingdomBritish108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Geschäftsführer
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    EnglandBritish74719200002
    GRAY, Jonathan David
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Geschäftsführer
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Usa65836770001
    HENNEBRY, Mark Nicholas
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    Geschäftsführer
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    IrelandIrish128404490001
    KUKRAL, John Zavertnik
    8 Rocky Point Road
    Old Greenwich
    Connecticut
    06870
    Usa
    Geschäftsführer
    8 Rocky Point Road
    Old Greenwich
    Connecticut
    06870
    Usa
    United StatesAmerican167484790001
    MCKENNA, Geraldine Maria Martina
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    Geschäftsführer
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    United KingdomIrish93995420001
    RAAFAT, Mahmoud
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarEgyptian271030610001
    REYNOLDS, Paul
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Geschäftsführer
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    EnglandBritish108281880001
    SEELINGER, Lisa Eleonora
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    Geschäftsführer
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    United KingdomAmerican128749960002
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Geschäftsführer
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    EnglandBritish138522860001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Raglan Real Estate Acquisition Company
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    06. Apr. 2016
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    Nein
    RechtsformPrivate Unlimited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House, England & Wales
    Registrierungsnummer03558968
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Jan. 2015
    Geliefert am 30. Jan. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited as Common Security Trustee (As Trustee for Each of the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 11. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Dez. 2012
    Geliefert am 08. Jan. 2013
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each debtor to any common secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 01. Apr. 2011
    Geliefert am 12. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over a bank account
    Erstellt am 01. Apr. 2011
    Geliefert am 12. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The account and the account balance. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2008
    Geliefert am 19. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The “Security Trustee”)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2008
    Geliefert am 19. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The “Security Trustee”)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Account charge
    Erstellt am 29. Juni 2006
    Geliefert am 19. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its present and future rights title interest and benefit whatsoever present and future in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Account charge
    Erstellt am 23. Sept. 2005
    Geliefert am 13. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title interest and benefit in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2005
    Geliefert am 11. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 06. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 14. Mai 2004
    Geliefert am 03. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Trustee for the Secured Parties (Thesecurity Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Junior mortgage of shares
    Erstellt am 05. Jan. 1999
    Geliefert am 15. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) andto the finance (junior agent) parties (as defined) under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Kurze Angaben
    All the shares; and all related rights accruing to the shares.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 05. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior mortgage of shares
    Erstellt am 05. Jan. 1999
    Geliefert am 15. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Kurze Angaben
    All the shares; and all related rights accrusing to the shares.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment and restatement(originally dated 7/4/98)
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 09. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under each finance document to which the company is a party
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 09. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between the company and merrill lynch international (the security trustee),as amended by the deed of amendment and restatement dated 30/4/98
    Erstellt am 07. Apr. 1998
    Geliefert am 11. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to any finance party under each finance document to which the company is a party
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merrill Lynch International (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0