BELMONT HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBELMONT HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03544570
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BELMONT HOMES LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich BELMONT HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Victory House
    Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BELMONT HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BELMONT HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:4.31-notice of appointment of liquidator: jermey willmont, david elliott & diane hill appointed 15/05/2015
    1 SeitenLIQ MISC

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    SeitenCOCOMP

    Ernennung eines Liquidators

    11 Seiten4.31

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2015

    2 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Jan. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Jan. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Jan. 2015

    2 Seiten3.6

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Comewell House North Street Horsham West Sussex RH12 1RD* am 06. Juni 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Sept. 2012 bis 27. Sept. 2012

    1 SeitenAA01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Sept. 2012 bis 28. Sept. 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Mai 2013

    Kapitalaufstellung am 28. Mai 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    15 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für David Daly am 09. Aug. 2012

    2 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von BELMONT HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DALY, David
    Apartamento 221
    Calle Alonso De Quijada No 57
    29600 Marbella
    Urbanizacion De Banus
    Malaga
    Spain
    Sekretär
    Apartamento 221
    Calle Alonso De Quijada No 57
    29600 Marbella
    Urbanizacion De Banus
    Malaga
    Spain
    IrishCompany Director66176880001
    DALY, David
    Estuary House
    New Street
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Estuary House
    New Street
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    SpainIrishCompany Director66176880003
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    WILLOWFIELD TRUST COMPANY LIMITED
    The Gables Torquay Road
    Foxrock
    18 Dublin
    Ireland
    Sekretär
    The Gables Torquay Road
    Foxrock
    18 Dublin
    Ireland
    60074210001
    DALY, Mary
    Estuary House
    New Street
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Estuary House
    New Street
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director65967080002
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EVANS, Terence George
    Bryher Island
    Port Solent
    PO6 4UE Portsmouth
    23
    Hants
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bryher Island
    Port Solent
    PO6 4UE Portsmouth
    23
    Hants
    United Kingdom
    BritishManaging Director134307400001
    RICKELL, David
    12 The Woodfields
    Sanderstead
    CR2 0HE South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    12 The Woodfields
    Sanderstead
    CR2 0HE South Croydon
    Surrey
    EnglandBritishQuantity Surveyor57890470001

    Hat BELMONT HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 2008
    Geliefert am 05. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at fairview road cheltenham t/no GR218705 and f/h land and buildings situate at albion street fairview road and gloucester place cheltenham t/nos GR188699, GR188809 and R188695 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Contract assignment
    Erstellt am 04. Mai 2007
    Geliefert am 11. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest whatsoever whether present or future arising out of or in to or under the assigned agreements including all claims for damages or other remedies in respect of any breach of any assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 11. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2007
    Geliefert am 12. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a new church road and 59/61 new church road hove t/no's SX99094 and SX148382,first fixed charge its interest in any existing and future proceeds of any insurance,its interest in any present or future licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 307. Feb. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 307. Apr. 2015Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 3
    Legal charge
    Erstellt am 24. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the east side of haydon place and the south side of the bars guildford surrey t/no SY742089 l/h land and buildings on the east side of haydon place and the south side of the bars guildford surrey t/no sy 742090 its interest in the proceeds of any insurance any present or future rental income all present and future fittings plant equipment machinery tools vehicles and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 207. Feb. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 207. Apr. 2015Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 12. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south east side of the bars haydon place guildford surrey. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 12. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 2005
    Geliefert am 12. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at martyr road,guildford,surrey t/no's SY387124,SY679884 and SY702794. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Nov. 2001
    Geliefert am 22. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the southwest side of market street cheltenham t/n GR237226.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 107. Feb. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 107. Apr. 2015Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2001
    Geliefert am 22. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south west side of market st,cheltenham; t/no gr 237226.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property known as 26 and 28 vachel road reading title numbers BK355346 and BK354789.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    114, 116 and 18 castle street reading. T/no BK239819.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the west of pattens lane chatham kent. T/no. BK582562.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and garages on the west side of bedford road. T/no. BK156198.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the west of pettens lane chatham kent. T/no. BK582652, land at 26-28 vachel road reading. T/no BK355346 and BK354789, 144, 116, 118 castle street reading. T/no. BK239819, land to the west of pettens lane chatham kent. T/no. K582652. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2001
    Geliefert am 10. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £4,800,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BELMONT HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Douglas Ernle Money
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Receiver Manager
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Receiver Manager
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Douglas Ernle Money
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Receiver Manager
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Receiver Manager
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Douglas Ernle Money
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Receiver Manager
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Receiver Manager
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    4
    DatumTyp
    05. Aug. 2016Abschluss der Liquidation
    06. Dez. 2013Antragsdatum
    03. März 2014Beginn der Liquidation
    26. Nov. 2016Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Brighton
    5th Floor Crown House, 11 Regent Hill
    BN1 3ED Brighton
    East Sussex
    Praktiker
    5th Floor Crown House, 11 Regent Hill
    BN1 3ED Brighton
    East Sussex
    Simon Geoffrey Paterson
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praktiker
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Diane Elizabeth Hill
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praktiker
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Ronald Elliott
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praktiker
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0