THE GRAY OX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE GRAY OX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03546158 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE GRAY OX LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich THE GRAY OX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Marston's House Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE GRAY OX LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Okt. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE GRAY OX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Okt. 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anne Marie Brennan als Sekretär am 05. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Michelle Louise Woodall als Sekretär am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Edward Hancock als Direktor am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Robert Anthony Leach als Direktor am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Hayleigh Lupino als Direktor am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ralph Graham Findlay als Geschäftsführer am 02. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Okt. 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard James Westwood als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Sept. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Dalzell als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Okt. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE GRAY OX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODALL, Michelle Louise | Sekretär | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | 288186670001 | |||||||
| ANDREA, Andrew Andonis | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | England | British | 137383120001 | |||||
| HANCOCK, Edward John | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 288133210001 | |||||
| LEACH, Robert Anthony | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 194085550001 | |||||
| LUPINO, Hayleigh | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 207826950002 | |||||
| BRENNAN, Anne Marie | Sekretär | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 109935620001 | ||||||
| GRAHAM, Granville | Sekretär | 40 Chadwick Lane WF14 8RA Mirfield West Yorkshire | British | 45842190002 | ||||||
| HODGSON, Mark Ian | Sekretär | Breeze Hill Portinscale CA12 5RW Keswick Cumbria | British | 97778860001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDREW, Derek | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 39071260003 | ||||||
| DALZELL, Peter | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | 163616170001 | |||||
| DARBY, Alistair William | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 87846880002 | ||||||
| FINDLAY, Ralph Graham | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marstons House West Midlands | England | British | 129897400001 | |||||
| GRAHAM, Ann Maria | Geschäftsführer | 40 Chadwick Lane WF14 8RA Mirfield West Yorkshire | British | 57762320002 | ||||||
| GRAHAM, Granville | Geschäftsführer | 40 Chadwick Lane WF14 8RA Mirfield West Yorkshire | British | 45842190002 | ||||||
| HOUGHTON, John | Geschäftsführer | 8 Rubbybanks Road CA13 9RG Cockermouth Cumbria | British | 73576380002 | ||||||
| INGLETT, Paul | Geschäftsführer | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 81617110002 | ||||||
| OLIVER, Stephen John | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 66123690003 | ||||||
| RYAN, Diane Mary | Geschäftsführer | 47 Headlands Close WF15 7QJ Liversedge West Yorkshire | British | 57762330003 | ||||||
| RYAN, Wayne Glen | Geschäftsführer | 47 Headlands Close WF15 7QJ Liversedge West Yorkshire | British | 57762340003 | ||||||
| STEVENSON, David Robert | Geschäftsführer | Rosemount Burgh By Sands CA5 6AN Carlisle Cumbria | England | British | 91952830001 | |||||
| WESTWOOD, Richard James | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | 314691870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE GRAY OX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marston's Acquisitions Limited | 06. Apr. 2016 | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THE GRAY OX LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Juni 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The gray ox,15 hartshead lane,hartshead,near liversedge,west yorkshire WF15 8AL; wyk 520438. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The boathouse victoria rd,saltaire,shipley,west yorkshire; wyk 252862;. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0