OUTER PROPERTY LTD
Überblick
| Unternehmensname | OUTER PROPERTY LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03553907 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OUTER PROPERTY LTD?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich OUTER PROPERTY LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o WILSON BARCA LLP Carlisle Buildings 18 Carlisle Street W1D 3BX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OUTER PROPERTY LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CAVENCO UK LIMITED | 13. Mai 1998 | 13. Mai 1998 |
| GINALT LIMITED | 28. Apr. 1998 | 28. Apr. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OUTER PROPERTY LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OUTER PROPERTY LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gregory Arthur Mihalcheon am 01. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Wilson Barca 13-14 Dean Street London W1D 3RS United Kingdom* am 16. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2011 bis 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OUTER PROPERTY LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIHALCHEON, Andrea | Sekretär | Wetherby Place SW7 4NU London 1 | British | 130302420001 | ||||||
| MIHALCHEON, Gregory Arthur | Geschäftsführer | Wetherby Place SW7 4NU London 1 England | England | Canadian | 58496250002 | |||||
| MCDONALD, Karen | Sekretär | 89 Cadogan Gardens SW3 2RE London | British | 96135290001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| WISE OWL SECRETAIRES LTD | Sekretär | 18a Pindock Mews Little Venice W9 2PY London | 72709230002 | |||||||
| PATERNOT, Madeleine Danielle | Geschäftsführer | Flat 3 59 Eardley Crescent SW5 9JT London | American | 58496450001 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OUTER PROPERTY LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Dean Street W1D 3RS London Carlisle Buildings England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OUTER PROPERTY LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 15. Sept. 2006 Geliefert am 29. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Flat 3, 24-26 hereford square kensington the property and the proceeds of sale of the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Apr. 2006 Geliefert am 22. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as hereford house 24-26 hereford square london and garages the l/h property known as flat 2 hereford house 24-26 hereford square london, the l/h property known as flat 5 hereford house 24-26 hereford square london, the l/h property known as the airspace above hereford house 24-26 hereford square london,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Okt. 2003 Geliefert am 18. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a second and third floor flat 5 hereford house 24 and 26 hereford square and garage no. 2 at the rear of 24 and 26 hereford square t/n's LN190468 and LN213807. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 17. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The sum of £555,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property k/a flat 5 hereford house 24 hereford square london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 04. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a flat 1 hereford house 24 hereford square london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 2002 Geliefert am 05. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £555,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a flat 2, hereford house, 24 hereford square, london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2002 Geliefert am 31. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0