THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED

THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 03558717
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2019
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2019
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verschiedenes

    Combined form b/z convert to rs
    1 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    12 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to rs 25/07/2018
    RES13

    Beendigung der Bestellung von John Philip Broadhead als Geschäftsführer am 21. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Angela Diane Mcclements als Geschäftsführer am 06. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    65 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Susan Lane als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Jones als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Helen Mansell Whittingham als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Andrew Overton als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Niku Mawby als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Harry Claus Ireland als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Laura Irene Hilditch als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Desmond Gerard Hudson als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Angela Diane Mcclements als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr James Dickson als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr John Philip Broadhead als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Anne Marie Ward als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul David James Weston als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Deborah Pauline Griffiths als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Annette Marie Shipley als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Danielle Oum als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Esther Leonie Wright als Direktor am 30. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung 035587170011, erstellt am 02. Okt. 2017

    33 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    60 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROGERSON, Catherine Maria
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Sekretär
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    228916990001
    DICKSON, James
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishRetired125336660001
    ESIMAJE-HEATH, Jacqueline Aminioritse
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector Of Strategic Projects181062270001
    FISHER, Alison Jane
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishNon Exec180811350001
    GRIFFITHS, Deborah Pauline
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishConsultant214306390001
    HUDSON, Desmond Gerard
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishCompany Director242664130001
    OUM, Danielle
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishNon Exec Director231209490001
    SHIPLEY, Annette Marie
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishManaging Director242646700001
    WARD, Anne Marie
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishChair154496190001
    WESTON, Paul David James
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishFinance Director61904620002
    WRIGHT, Esther Leonie
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishDirector131462320002
    GILES, Karen Eileen
    29 Windsor Avenue
    E17 5NL London
    Sekretär
    29 Windsor Avenue
    E17 5NL London
    British58123890001
    HORTON, Christopher John
    81 Compton Road
    WV3 9QH Wolverhampton
    Sekretär
    81 Compton Road
    WV3 9QH Wolverhampton
    British37400090004
    MOORES, Christopher John
    14 Ragleth Road
    SY6 7BN Church Stretton
    Shropshire
    Sekretär
    14 Ragleth Road
    SY6 7BN Church Stretton
    Shropshire
    British61381930001
    ALVEY, John Robert
    46 Haygate Road
    Wellington
    TF1 1QN Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    46 Haygate Road
    Wellington
    TF1 1QN Telford
    Salop
    BritishTeacher70857410001
    ATHERSMITH, Roy
    59 Ardern Avenue
    Dawley
    TF4 2AL Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    59 Ardern Avenue
    Dawley
    TF4 2AL Telford
    Salop
    BritishTelford Wrekin Counciller28998870001
    BARBER, John Walter
    32 Ercall View
    TF3 5AP Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    32 Ercall View
    TF3 5AP Telford
    Salop
    BritishRetired64656420001
    BARTLETT, Karl
    67 Jubilee Avenue
    Donnington
    TF2 8HR Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    67 Jubilee Avenue
    Donnington
    TF2 8HR Telford
    Salop
    BritishRoyal Mail72885770001
    BEST, Francis Paul
    April Cottage
    Ford Heath
    SY5 9NW Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    April Cottage
    Ford Heath
    SY5 9NW Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishFinance Director73448600001
    BROADHEAD, John Philip
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    United KingdomBritishChief Executive242649380001
    BROTHERTON, Margaret Ann (Margo)
    18 Adams Crescent
    TF10 7QJ Newport
    Salop
    Geschäftsführer
    18 Adams Crescent
    TF10 7QJ Newport
    Salop
    EnglandBritishWaitress70541840002
    CHAVE, John Howard Benjamin
    32 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    Geschäftsführer
    32 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    BritishSolicitor57774160002
    CLAYTON, John Anthony
    The Higher House
    Grinshill
    SY4 3BN Shrewsbury
    Geschäftsführer
    The Higher House
    Grinshill
    SY4 3BN Shrewsbury
    EnglandBritishChartered Surveyor12135130003
    COPSON, Andrew Nicholas
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    Geschäftsführer
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishProperty Developer122559290001
    COPSON, Andrew Nicholas
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    Geschäftsführer
    25 The Mount
    SY3 8PT Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishConsultant122559290001
    CRUISE, Celia
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    Shropshire
    EnglandBritishRetired Secretary182385340001
    DAVIS, Ian Martin Kitredge
    34 Raynham Street
    SG13 7DE Hertford
    Herts
    Geschäftsführer
    34 Raynham Street
    SG13 7DE Hertford
    Herts
    BritishSolicitor57774150001
    DUCE, Jeremy Charles Stephen
    10 Regent Square
    Madeley
    TF7 5EA Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    10 Regent Square
    Madeley
    TF7 5EA Telford
    Shropshire
    BritishRetired78370270001
    EADE, Andrew John
    Rowton Stables
    Rowton
    TF6 6QY Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Rowton Stables
    Rowton
    TF6 6QY Telford
    Shropshire
    BritishCompany Director43091790004
    ELDRIDGE, George Donald
    18 Withington Close
    Oakengates
    TF2 6JR Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    18 Withington Close
    Oakengates
    TF2 6JR Telford
    Salop
    BritishRetired62638040001
    FLETCHER, Ian Thomas Wells
    67 Derwent Drive
    Priorslee
    TF2 9QR Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    67 Derwent Drive
    Priorslee
    TF2 9QR Telford
    Shropshire
    EnglandBritishBusiness Analyst59199820001
    FLINT, Susan Pamela
    28 Wordsworth Way
    Priorslee
    TF2 9RW Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    28 Wordsworth Way
    Priorslee
    TF2 9RW Telford
    Shropshire
    BritishSelf Employed55708270001
    FLOYD, Robert Glen
    5 Berrystead
    CW8 1NG Hartford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Berrystead
    CW8 1NG Hartford
    Cheshire
    EnglandBritishConsultant80471840001
    GARBETT, Peter Robert
    37 Trinity Road
    Dawley
    TF4 3EW Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    37 Trinity Road
    Dawley
    TF4 3EW Telford
    Salop
    BritishCarer61382830001
    GWYNNE, Jean
    38 Meadow Road
    TF10 7TH Newport
    Salop
    Geschäftsführer
    38 Meadow Road
    TF10 7TH Newport
    Salop
    BritishHousewife61382680001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    The Wrekin Housing Group Limited
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    The Wrekin Housing Trust
    England
    06. Apr. 2016
    Colliers Way
    Old Park
    TF3 4AW Telford
    The Wrekin Housing Trust
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Guarantee
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 1985
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer5032634
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Okt. 2017
    Geliefert am 10. Okt. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    9 dorran place, st georges, as registered at the land registry (title number SL119848 and SL119846) for further details please see schedule 1 of the legal mortgage.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2016
    Geliefert am 04. Nov. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Unit 5, stirchley district centre, stirchley, telford, TF3 1ET (registered at the land registry with title number SL238150). For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 04. März 2016
    Geliefert am 09. März 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1 athersmith close title number SL117391. To see all charges, please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 09. März 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 23. Dez. 2015
    Geliefert am 04. Jan. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The freehold property being 2 bower form drive, st martins, registered at the land registry under title number SL231484. Please refer to schedule 1 of the legal mortgage for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Nov. 2015
    Geliefert am 05. Nov. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The freehold property being 1 balmoral court, captain webb drive registered at the land registry under title number SL206751. Please refer to schedule 1 of the fixed charge for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Fixed charge
    Erstellt am 29. März 2012
    Geliefert am 05. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SL26279 43 south drive madeley telford, SL183575 33 the smithfields newport, SL44624 155 willowfield woodside telford, for further details of properties charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Form of fixed charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 27. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the property together with all the buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale.all plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge and assignment
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 20. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All of the obligations which the company may at any time have to the chargee (whether for its own account or as agent and trustee for the secured parties or any of the secured parties pursuant to a loan facility agreement each certificate of novation effected pursuant to the provisions of the said loan facility agreement a letter of agreement relating to the day to day banking facilities including overdraft and settlement limits any fixed floating charge or account charge or any other document creating evidencing or granting security entered into by the company and/or in favour of the chargee pursuant to the provisions of the said loan facility agreement dated 25 march 1999 (all terms defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that leasehold property known as the wrekin head office, colliers way, old park, telford, shropshire pursuant to the lease. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society in Its Own Capacity Os Arranger and Lender Andas Agent and Trustee for National Westminster Bank PLC in Its Capacity as Agent, Arranger and Lender and Barclays Bank PLC, Abbey National Treasury Service PLC and Britannia Building Society
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge between the company and nationwide building society as security agent and trustee of the security constituted under the charge for itself and the finance parties (as defined)
    Erstellt am 25. März 1999
    Geliefert am 02. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities owed by the borrower to each finance party under or in connection with the finance documents
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge
    Erstellt am 25. März 1999
    Geliefert am 02. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent) owed by the company to the chargee as security agent and trustee of the security constituted under the charge for itself and the finance parties (as defined) or any of them under or in connection with any of the finance documents (the "secured liabilities")
    Kurze Angaben
    By way of first fixed legal mortgage all the property referred to in schedule 1 together with all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale of all or any part thereof and (so far as the same are capable of being mortgaged) the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the borrower and any monies paid or payable in respect of such covenants;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Account charge
    Erstellt am 25. März 1999
    Geliefert am 02. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent) owed by the company to the chargee as security agent and trustee of the security constituted under this charge for itself and the finance parties (as defined) or any of them under or in connection with any of the finance documents (the "secured liabilities")
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all moneys (including interest) from time to time standing to the credit of: (a) the proceeds account; and (b) the sinking fund and the debts represented thereby.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0