THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED
Überblick
Unternehmensname | THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
Unternehmensnummer | 03558717 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2019 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2019 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Combined form b/z convert to rs | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Philip Broadhead als Geschäftsführer am 21. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angela Diane Mcclements als Geschäftsführer am 06. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 65 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susan Lane als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Jones als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Mansell Whittingham als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Andrew Overton als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Niku Mawby als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Harry Claus Ireland als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Laura Irene Hilditch als Geschäftsführer am 30. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Desmond Gerard Hudson als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Angela Diane Mcclements als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Dickson als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Philip Broadhead als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Anne Marie Ward als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul David James Weston als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Deborah Pauline Griffiths als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Annette Marie Shipley als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Danielle Oum als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Esther Leonie Wright als Direktor am 30. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 035587170011, erstellt am 02. Okt. 2017 | 33 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 60 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGERSON, Catherine Maria | Sekretär | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | 228916990001 | |||||||
DICKSON, James | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | United Kingdom | British | Retired | 125336660001 | ||||
ESIMAJE-HEATH, Jacqueline Aminioritse | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | United Kingdom | British | Director Of Strategic Projects | 181062270001 | ||||
FISHER, Alison Jane | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | England | British | Non Exec | 180811350001 | ||||
GRIFFITHS, Deborah Pauline | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | United Kingdom | British | Consultant | 214306390001 | ||||
HUDSON, Desmond Gerard | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | United Kingdom | British | Company Director | 242664130001 | ||||
OUM, Danielle | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | England | British | Non Exec Director | 231209490001 | ||||
SHIPLEY, Annette Marie | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | England | British | Managing Director | 242646700001 | ||||
WARD, Anne Marie | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | England | British | Chair | 154496190001 | ||||
WESTON, Paul David James | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | United Kingdom | British | Finance Director | 61904620002 | ||||
WRIGHT, Esther Leonie | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | England | British | Director | 131462320002 | ||||
GILES, Karen Eileen | Sekretär | 29 Windsor Avenue E17 5NL London | British | 58123890001 | ||||||
HORTON, Christopher John | Sekretär | 81 Compton Road WV3 9QH Wolverhampton | British | 37400090004 | ||||||
MOORES, Christopher John | Sekretär | 14 Ragleth Road SY6 7BN Church Stretton Shropshire | British | 61381930001 | ||||||
ALVEY, John Robert | Geschäftsführer | 46 Haygate Road Wellington TF1 1QN Telford Salop | British | Teacher | 70857410001 | |||||
ATHERSMITH, Roy | Geschäftsführer | 59 Ardern Avenue Dawley TF4 2AL Telford Salop | British | Telford Wrekin Counciller | 28998870001 | |||||
BARBER, John Walter | Geschäftsführer | 32 Ercall View TF3 5AP Telford Salop | British | Retired | 64656420001 | |||||
BARTLETT, Karl | Geschäftsführer | 67 Jubilee Avenue Donnington TF2 8HR Telford Salop | British | Royal Mail | 72885770001 | |||||
BEST, Francis Paul | Geschäftsführer | April Cottage Ford Heath SY5 9NW Shrewsbury Shropshire | England | British | Finance Director | 73448600001 | ||||
BROADHEAD, John Philip | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 242649380001 | ||||
BROTHERTON, Margaret Ann (Margo) | Geschäftsführer | 18 Adams Crescent TF10 7QJ Newport Salop | England | British | Waitress | 70541840002 | ||||
CHAVE, John Howard Benjamin | Geschäftsführer | 32 Macaulay Road SW4 0QX London | British | Solicitor | 57774160002 | |||||
CLAYTON, John Anthony | Geschäftsführer | The Higher House Grinshill SY4 3BN Shrewsbury | England | British | Chartered Surveyor | 12135130003 | ||||
COPSON, Andrew Nicholas | Geschäftsführer | 25 The Mount SY3 8PT Shrewsbury Salop | England | British | Property Developer | 122559290001 | ||||
COPSON, Andrew Nicholas | Geschäftsführer | 25 The Mount SY3 8PT Shrewsbury Salop | England | British | Consultant | 122559290001 | ||||
CRUISE, Celia | Geschäftsführer | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford Shropshire | England | British | Retired Secretary | 182385340001 | ||||
DAVIS, Ian Martin Kitredge | Geschäftsführer | 34 Raynham Street SG13 7DE Hertford Herts | British | Solicitor | 57774150001 | |||||
DUCE, Jeremy Charles Stephen | Geschäftsführer | 10 Regent Square Madeley TF7 5EA Telford Shropshire | British | Retired | 78370270001 | |||||
EADE, Andrew John | Geschäftsführer | Rowton Stables Rowton TF6 6QY Telford Shropshire | British | Company Director | 43091790004 | |||||
ELDRIDGE, George Donald | Geschäftsführer | 18 Withington Close Oakengates TF2 6JR Telford Salop | British | Retired | 62638040001 | |||||
FLETCHER, Ian Thomas Wells | Geschäftsführer | 67 Derwent Drive Priorslee TF2 9QR Telford Shropshire | England | British | Business Analyst | 59199820001 | ||||
FLINT, Susan Pamela | Geschäftsführer | 28 Wordsworth Way Priorslee TF2 9RW Telford Shropshire | British | Self Employed | 55708270001 | |||||
FLOYD, Robert Glen | Geschäftsführer | 5 Berrystead CW8 1NG Hartford Cheshire | England | British | Consultant | 80471840001 | ||||
GARBETT, Peter Robert | Geschäftsführer | 37 Trinity Road Dawley TF4 3EW Telford Salop | British | Carer | 61382830001 | |||||
GWYNNE, Jean | Geschäftsführer | 38 Meadow Road TF10 7TH Newport Salop | British | Housewife | 61382680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Wrekin Housing Group Limited | 06. Apr. 2016 | Colliers Way Old Park TF3 4AW Telford The Wrekin Housing Trust England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat THE WREKIN HOUSING TRUST LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 02. Okt. 2017 Geliefert am 10. Okt. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 9 dorran place, st georges, as registered at the land registry (title number SL119848 and SL119846) for further details please see schedule 1 of the legal mortgage. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 04. Nov. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Unit 5, stirchley district centre, stirchley, telford, TF3 1ET (registered at the land registry with title number SL238150). For more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 04. März 2016 Geliefert am 09. März 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 1 athersmith close title number SL117391. To see all charges, please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. Dez. 2015 Geliefert am 04. Jan. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The freehold property being 2 bower form drive, st martins, registered at the land registry under title number SL231484. Please refer to schedule 1 of the legal mortgage for more details. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 02. Nov. 2015 Geliefert am 05. Nov. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The freehold property being 1 balmoral court, captain webb drive registered at the land registry under title number SL206751. Please refer to schedule 1 of the fixed charge for more details. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 29. März 2012 Geliefert am 05. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben SL26279 43 south drive madeley telford, SL183575 33 the smithfields newport, SL44624 155 willowfield woodside telford, for further details of properties charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Form of fixed charge | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 27. Feb. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the property together with all the buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale.all plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge and assignment | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 20. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All of the obligations which the company may at any time have to the chargee (whether for its own account or as agent and trustee for the secured parties or any of the secured parties pursuant to a loan facility agreement each certificate of novation effected pursuant to the provisions of the said loan facility agreement a letter of agreement relating to the day to day banking facilities including overdraft and settlement limits any fixed floating charge or account charge or any other document creating evidencing or granting security entered into by the company and/or in favour of the chargee pursuant to the provisions of the said loan facility agreement dated 25 march 1999 (all terms defined) | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all that leasehold property known as the wrekin head office, colliers way, old park, telford, shropshire pursuant to the lease. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge between the company and nationwide building society as security agent and trustee of the security constituted under the charge for itself and the finance parties (as defined) | Erstellt am 25. März 1999 Geliefert am 02. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities owed by the borrower to each finance party under or in connection with the finance documents | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 25. März 1999 Geliefert am 02. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent) owed by the company to the chargee as security agent and trustee of the security constituted under the charge for itself and the finance parties (as defined) or any of them under or in connection with any of the finance documents (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben By way of first fixed legal mortgage all the property referred to in schedule 1 together with all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale of all or any part thereof and (so far as the same are capable of being mortgaged) the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the borrower and any monies paid or payable in respect of such covenants;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Account charge | Erstellt am 25. März 1999 Geliefert am 02. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent) owed by the company to the chargee as security agent and trustee of the security constituted under this charge for itself and the finance parties (as defined) or any of them under or in connection with any of the finance documents (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all moneys (including interest) from time to time standing to the credit of: (a) the proceeds account; and (b) the sinking fund and the debts represented thereby.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0