PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03562121 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRUSHELFCO (NO.2367) LIMITED | 12. Mai 1998 | 12. Mai 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
legacy | 86 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||
Beendigung der Bestellung von David Forde als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||
legacy | 79 Seiten | PARENT_ACC | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von David James Tannahill als Geschäftsführer am 24. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Sean Michael Paterson als Direktor am 24. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 24. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 3 Seiten | AA | ||
Change of details for Punch Partnerships (Ptl) Limited as a person with significant control on 04. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF zum Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE am 08. Sept. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Peter Dando als Geschäftsführer am 29. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Francesca Appleby als Sekretär am 29. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Edward Michael Bashforth als Geschäftsführer am 29. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr David Forde als Direktor am 29. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Christopher John Moore als Direktor am 29. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Geschäftsführer | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191628630001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Sekretär | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175489260001 | |||||||
| MCINTOSH, William Alan | Sekretär | 7 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 46361590002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161798460001 | |||||||
| TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||
| BARTON, Andrew | Geschäftsführer | 102 Tottenham Road Islington N1 4DP London | British | 58939560001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FORDE, David | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| HYMAN, Neil | Geschäftsführer | The Campions 42 Beech Hill Avenue Hadley Wood EN4 0LU Barnet Hertfordshire | British | 58207580001 | ||||||
| JONAS, Marc Nicholas | Geschäftsführer | 48 Oxford Gardens W10 5UN London | United Kingdom | British | 55841850003 | |||||
| KEMP, Deborah Jane | Geschäftsführer | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MCINTOSH, William Alan | Geschäftsführer | 7 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 46361590002 | ||||||
| MYERS, Roger | Geschäftsführer | Fern Lodge 5 Millfield Lane Highgate N6 6JL London | United Kingdom | British | 56413030004 | |||||
| OSMOND, Hugh | Geschäftsführer | 10 Wellington Road NW8 9SP London | British | 6209210002 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| RIKLIN, Cornel Carl | Geschäftsführer | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | 78412270001 | |||||
| ROWE, Drusilla Charlotte Jane | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat E 13 Saint Georges Drive SW1V 4DJ London | British | 900010990001 | ||||||
| SHURE, Randl Louis | Geschäftsführer | 45 Addison Road W14 8JH London | Usa | 57895060001 | ||||||
| TANNAHILL, David James | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Geschäftsführer | Charlton Manor Ashley Road Charlton Kings GL52 6NS Cheltenham Gloucestershire | Gb-Eng | British | 81928120001 | |||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 26 Springfield Road Linslade LU7 7QS Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 900014530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29. Aug. 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Partnerships (Ptl) Limited | 06. Apr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PUNCH TAVERNS (FRADLEY) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second ranking fixed and floating security document | Erstellt am 08. Dez. 2006 Geliefert am 18. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 16. Jan. 2006 Geliefert am 23. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First legal mortgage all property in england and wales,first fixed euitable charge all other property,first fixed charge all its present and future book debts,bank accounts,investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Okt. 2000 Geliefert am 04. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold land to the rear of 76 bank st,maidstone,kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Sept. 2000 Geliefert am 08. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the high flyer public house 69 newnham street ely cambridgeshire. T/no. CB137859. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Sept. 2000 Geliefert am 08. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the white hart hacton lane upminster RM14 2YF london borough of havering. T/no. S EX80936 P81215 and NGL144679. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 2000 Geliefert am 10. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The pub with no name southover street brighton.t/no.SX133345. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 2000 Geliefert am 10. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The belle vue public house,gordon road,high wycombe.t/no.BM195110. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 2000 Geliefert am 10. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cork & bull public house 4 cumberland place street luton.t/no.BD23398. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Elm park hotel 20 cavendish place eastbourne BN21 3EJ. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Wheelers public house (formerly k/a the castle public house) 156 leyton road stratford E15 1DR. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The bent brief public house 15/17 lodge road bevois valley southampton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The welcome public house fullbridge maldon essex t/n's ESX93854 and EX617696. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The millers arms 1 windmill street brighton t/n SX133355. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The grizzleys public house 301 arundel street portsmouth t/n HP459512. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The bird of pride public house 293 sydenham road west croydon t/n SGL613434. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The beat bar public house 76 bank street maidstone t/n K687272. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The spread eagle public house 25 victoria road margate t/n ESX74075. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The crown inn public house ferry road rye t/n's ESX76600 and ESX74075. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Juni 2000 Geliefert am 06. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Harry aj's harrison street horwich bolton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Juni 2000 Geliefert am 06. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Gallaghers oyster bar 231 st george's road bolton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Mai 2000 Geliefert am 25. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The white swan,old maltongate,york. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Mai 2000 Geliefert am 11. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The nags head public house st leonards on sea east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Apr. 2000 Geliefert am 27. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The forge tavern, st annes road, willenhall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Apr. 2000 Geliefert am 27. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The northern inn cobwell road retford nottinghamshire DN22 7BW. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Apr. 2000 Geliefert am 27. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The rifle volunteer public house forest road skegby sutton in ashfield NG17 3BL plumbers arms 76 wylds lane worcester WR5 1DF. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0