ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED

ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03562201
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O GRANT THORNTON UK LLP
    Earl Grey House 75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MOTORBIKE DIRECT LIMITED12. Mai 199812. Mai 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Feb. 2010

    5 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 13. Feb. 2010

    5 Seiten2.35B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 13. Feb. 2010

    10 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Aug. 2009

    6 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    12 Seiten2.23B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    13 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    12 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    2 Seiten88(2)R

    legacy

    2 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 320 05/04/07
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MILESON, Brooks George
    The Hill
    Blackford
    CA6 4DZ Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    The Hill
    Blackford
    CA6 4DZ Carlisle
    Cumbria
    British53089030001
    MILESON, Craig
    5 The Woodlands
    Hayton
    Oak House`
    Cumbria
    England
    Geschäftsführer
    5 The Woodlands
    Hayton
    Oak House`
    Cumbria
    England
    British128457950001
    WARRINER, William Phillip
    Tudor Drive
    Tanfield
    DH9 9QD Stanley
    38
    Co Durham
    England
    Geschäftsführer
    Tudor Drive
    Tanfield
    DH9 9QD Stanley
    38
    Co Durham
    England
    EnglandBritish127982920001
    GROOTENDORST, Paul Jan Herman
    20 Weymouth Drive
    Biddick Woods
    DH4 7TQ Houghton Le Spring
    County Durham
    Sekretär
    20 Weymouth Drive
    Biddick Woods
    DH4 7TQ Houghton Le Spring
    County Durham
    British76872050002
    MILESON, Colin Paul
    14 Magdalene Place
    Millfield
    SR4 6LW Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    14 Magdalene Place
    Millfield
    SR4 6LW Sunderland
    Tyne & Wear
    British109579220001
    NICHOLSON, Sandra
    8 Westgate Avenue
    SR3 1BD Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    8 Westgate Avenue
    SR3 1BD Sunderland
    Tyne & Wear
    British66481060001
    O'BRIEN, John
    Hawthorne Farmhouse, Ince Lane
    Wimbolds Trafford
    CH2 4JP Chester
    Cheshire
    Sekretär
    Hawthorne Farmhouse, Ince Lane
    Wimbolds Trafford
    CH2 4JP Chester
    Cheshire
    British110825330001
    WARRINER, William Phillip
    Tudor Drive
    Tanfield
    DH9 9QD Stanley
    38
    Co Durham
    England
    Sekretär
    Tudor Drive
    Tanfield
    DH9 9QD Stanley
    38
    Co Durham
    England
    British127982920001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    WB COMPANY SECRETARIES LIMITED
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    37945630002
    GRAHAM, Michael John
    3a Hylton Road
    TS26 0AD Hartlepool
    Cleveland
    Geschäftsführer
    3a Hylton Road
    TS26 0AD Hartlepool
    Cleveland
    EnglandBritish66480480001
    GROOTENDORST, Paul Jan Herman
    20 Weymouth Drive
    Biddick Woods
    DH4 7TQ Houghton Le Spring
    County Durham
    Geschäftsführer
    20 Weymouth Drive
    Biddick Woods
    DH4 7TQ Houghton Le Spring
    County Durham
    United KingdomBritish76872050002
    MORL, Ian Michael
    9 Rowland Crescent
    Castle Eden
    TS27 4FE Hartlepool
    Cleveland
    Geschäftsführer
    9 Rowland Crescent
    Castle Eden
    TS27 4FE Hartlepool
    Cleveland
    United KingdomBritish109450600001
    QUIGLEY, Brian Dominic
    16 Hermitage Gardens
    DH2 3UD Chester Le Street
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    16 Hermitage Gardens
    DH2 3UD Chester Le Street
    Tyne & Wear
    EnglandBritish89841760001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001
    WB COMPANY DIRECTORS LIMITED
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    41947520001

    Hat ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 05. Apr. 2007
    Geliefert am 13. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 22ND september 2004
    Erstellt am 02. Sept. 2006
    Geliefert am 14. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Erstellt am 19. Sept. 2005
    Geliefert am 04. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 22 september 2004
    Erstellt am 21. Okt. 2004
    Geliefert am 26. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Omnibus letter of set-off
    Erstellt am 22. Sept. 2004
    Geliefert am 07. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 25. März 2003
    Geliefert am 08. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 2000
    Geliefert am 24. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ARNGROVE GROUP HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Feb. 2010Ende der Verwaltung
    17. Feb. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Keith Hinds
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0