CAROLITA SHIPPING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CAROLITA SHIPPING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03565160 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAROLITA SHIPPING LIMITED?
- See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich CAROLITA SHIPPING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Höegh Capital Partners Services Limited 5 Young Street W8 5EH London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAROLITA SHIPPING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
POTTERCLOSE LIMITED | 15. Mai 1998 | 15. Mai 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAROLITA SHIPPING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CAROLITA SHIPPING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Everard als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Leif Hoegh Uk Ltd 150 Minories London EC3N 1LS zum C/O Höegh Capital Partners Services Limited 5 Young Street London W8 5EH am 27. Sept. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth Malcolm Bailey als Direktor am 16. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr per Oivind Rosmo als Direktor am 02. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Olav Sollie als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Olav Sollie als Direktor am 09. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Cathrine Kristiseter Marti als Geschäftsführer am 09. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , C/O Leif Hoegh Uk Ltd, 4 Royal Mint Court, London, EC3N 4HJ, United Kingdom am 14. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Erik Norman am 01. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAROLITA SHIPPING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAILEY, Kenneth Malcolm | Geschäftsführer | 5 Young Street W8 5EH London C/O Höegh Capital Partners Services Limited England | United Kingdom | British | Director | 124641150002 | ||||
NORMAN, Erik | Geschäftsführer | 5 Young Street W8 5EH London C/O Höegh Capital Partners Services Limited England | Norway | Norwegian | Svp Finance | 80398380001 | ||||
ROSMO, Per Oivind | Geschäftsführer | 5 Young Street W8 5EH London C/O Höegh Capital Partners Services Limited England | Norway | Norwegian | Head Of Reporting Accounting And Control | 193931030001 | ||||
CARON DELION, Patrick | Sekretär | 4 Esmond Road W4 1JQ London | Other | 95892040003 | ||||||
CARON DELION, Patrick | Sekretär | First Floor Flat 39 Nevern Square SW5 9PE London | British | Solicitor/Lease Arranger | 95892040001 | |||||
HUGHES, Haydn Philip | Sekretär | 5 Beechen Grove HA5 3AH Pinner Middlesex | British | 23300890001 | ||||||
LEWIN, Alastair Giles | Sekretär | 19 Severnake Close Isle Of Dogs E14 9WE London | British | 73905180001 | ||||||
SWANNELL, David William | Sekretär | 5c Hyde Park Mansions Transept Street NW1 5ES London | British | Financier | 72665990002 | |||||
THORP, Richard Simon | Sekretär | 26 Murray Mews Camden NW1 9RJ London | British | 98514070001 | ||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
CARON DELION, Patrick | Geschäftsführer | 4 Esmond Road W4 1JQ London | England | Other | Financier | 95892040003 | ||||
CHARLTON, Peter John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||
EVERARD, Christopher John | Geschäftsführer | c/o Höegh Capital Partners Services Limited Young Street W8 5EH London 5 England | United Kingdom | British | Accountant | 147196820001 | ||||
GRIFFIN, Philip Mark | Geschäftsführer | 51 Olola Avenue 2030 Vaucluse Nsw Australia | Australian | Financier | 49828980005 | |||||
HARRIS, Braden | Geschäftsführer | Flat D 41 Lancaster Grove NW3 4HB London | United Kingdom | British | Financier | 72069860002 | ||||
JOBANPUTRA, Sandip | Geschäftsführer | 7 High Holborn Flat 110 WC1V 6DR London | Uk | British | Financier | 83069380001 | ||||
KAYSER, Simon Philip | Geschäftsführer | Apartment 91 Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street E1W 1NG London | England | British | Financier | 99475270002 | ||||
MARTI, Cathrine Kristiseter | Geschäftsführer | c/o Leif Hoegh Uk Ltd Minories EC3N 1LS London 150 England | Norway | Norwegian | Head Of Finance | 147197110001 | ||||
RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
SOLLIE, Olav | Geschäftsführer | c/o Leif Hoegh Uk Ltd Minories EC3N 1LS London 150 | Norway | Norwegian | Head Of Shipowning | 192106790001 | ||||
SWANNELL, David William | Geschäftsführer | 55 Albion Gate Hyde Park Place W2 2LG London | British | Financier | 72665990003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAROLITA SHIPPING LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoegh Autoliners (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Young Street W8 5EH London 5 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CAROLITA SHIPPING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A first priority norwegian ship mortgage | Erstellt am 05. Okt. 2006 Geliefert am 23. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The vessel "hoegh treasure" registered with imo number 9184859 and in her equipment and appurtenances and including the proceeds of all insurance sums for the ship. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of general assignment and covenant | Erstellt am 13. Okt. 2005 Geliefert am 18. Okt. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all policies of insurance in relation to "hual treasure" (the vessel) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the vessel and all moneys payable which arise out of the use or operation of the vessel. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Ship mortgage | Erstellt am 13. Okt. 2005 Geliefert am 18. Okt. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All sixty-fourth shares in the vessel "hual carolita". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed of general assignment | Erstellt am 01. Dez. 2003 Geliefert am 05. Dez. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company; carolita shipping limited; allco finance (UK) limited; aus shipping LTD; allocean limited; or leif hoegh & co asa to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the right, title and interest, present and future, in, to and under a deed of general assignment dated 20 march 2000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of general assignment between the company, allco finance limited (the "general partner"), allco finance (UK) limited (the "sponsor") and lloyds commercial leasing limited (the "investor") in favour of lloyds tsb bank PLC in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and certain other beneficiaries (the "security trustee") | Erstellt am 20. März 2000 Geliefert am 03. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys, liabilities and obligations due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with any documents from time to time designated as "transaction documents" by each of the general partner, the investor, the bank guarantor and uih | |
Kurze Angaben Right title and interest under a deed of general assignment, a time charter, a guarantee dated 20 march 2000, the benefit of the insurances in respect of the said vessel and any compensation. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Ship mortgage | Erstellt am 10. Mai 1999 Geliefert am 18. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee set forth in the participation agreement and the deed and in order to secure the performance of all monies due or to become due from the company to the chargee thereunder (the amount of principal, interest and all other monies due at any given time being ascertainable by reference to the participation agreement , the deed and/or books of accounts or other accounting records of the bank). | |
Kurze Angaben All sixty-four sixty fourth shares of the company in the vessel "hual carolita" registered under bahamanian flag at the port of nassau with official number 732202. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture creating a floating charge postponed to all other security interest between carolita shipping limited and lloyds bank PLC | Erstellt am 04. Sept. 1998 Geliefert am 22. Sept. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies liabilities and obligations due or to become due from or by the company and/or all or any of the security parties (as defined) to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of general assignment and covenant between the company (as owner), allco finance limited (as general partner), allco finance limited (as sponsor), lloyds commercial leasing limited (as investor) and lloyds bank PLC (as assignee) | Erstellt am 04. Sept. 1998 Geliefert am 22. Sept. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each a "security party") to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to a). The insurances b). Any requisition compensation and c). All sums of money on or from the date of creation of the charge standing to the credit of an account and all related rights thereto and thereof d). The charterparty the construction supervision agreement, the uih guarantee of charter and secondary put option and all claims rights and remedies of that assignor arising therefrom (inc. All damages and compensation payable) e). The novated shipbuilding contract and the novation agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0