CAROLITA SHIPPING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAROLITA SHIPPING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03565160
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    5 Young Street
    W8 5EH London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POTTERCLOSE LIMITED15. Mai 199815. Mai 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Christopher John Everard als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Leif Hoegh Uk Ltd 150 Minories London EC3N 1LS zum C/O Höegh Capital Partners Services Limited 5 Young Street London W8 5EH am 27. Sept. 2016

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Kenneth Malcolm Bailey als Direktor am 16. Sept. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 18. Mai 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    5 SeitenAA

    Ernennung von Mr per Oivind Rosmo als Direktor am 02. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Olav Sollie als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Olav Sollie als Direktor am 09. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Cathrine Kristiseter Marti als Geschäftsführer am 09. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    5 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , C/O Leif Hoegh Uk Ltd, 4 Royal Mint Court, London, EC3N 4HJ, United Kingdom am 14. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Erik Norman am 01. Sept. 2011

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAILEY, Kenneth Malcolm
    5 Young Street
    W8 5EH London
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    England
    Geschäftsführer
    5 Young Street
    W8 5EH London
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    England
    United KingdomBritishDirector124641150002
    NORMAN, Erik
    5 Young Street
    W8 5EH London
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    England
    Geschäftsführer
    5 Young Street
    W8 5EH London
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    England
    NorwayNorwegianSvp Finance80398380001
    ROSMO, Per Oivind
    5 Young Street
    W8 5EH London
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    England
    Geschäftsführer
    5 Young Street
    W8 5EH London
    C/O Höegh Capital Partners Services Limited
    England
    NorwayNorwegianHead Of Reporting Accounting And Control193931030001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Sekretär
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Other95892040003
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Sekretär
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    BritishSolicitor/Lease Arranger95892040001
    HUGHES, Haydn Philip
    5 Beechen Grove
    HA5 3AH Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    5 Beechen Grove
    HA5 3AH Pinner
    Middlesex
    British23300890001
    LEWIN, Alastair Giles
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    Sekretär
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    British73905180001
    SWANNELL, David William
    5c Hyde Park Mansions
    Transept Street
    NW1 5ES London
    Sekretär
    5c Hyde Park Mansions
    Transept Street
    NW1 5ES London
    BritishFinancier72665990002
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Sekretär
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Geschäftsführer
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOtherFinancier95892040003
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    EVERARD, Christopher John
    c/o Höegh Capital Partners Services Limited
    Young Street
    W8 5EH London
    5
    England
    Geschäftsführer
    c/o Höegh Capital Partners Services Limited
    Young Street
    W8 5EH London
    5
    England
    United KingdomBritishAccountant147196820001
    GRIFFIN, Philip Mark
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Geschäftsführer
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    AustralianFinancier49828980005
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Geschäftsführer
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritishFinancier72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Geschäftsführer
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritishFinancier83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Geschäftsführer
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritishFinancier99475270002
    MARTI, Cathrine Kristiseter
    c/o Leif Hoegh Uk Ltd
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    England
    Geschäftsführer
    c/o Leif Hoegh Uk Ltd
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    England
    NorwayNorwegianHead Of Finance147197110001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SOLLIE, Olav
    c/o Leif Hoegh Uk Ltd
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    Geschäftsführer
    c/o Leif Hoegh Uk Ltd
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    NorwayNorwegianHead Of Shipowning192106790001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Geschäftsführer
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    BritishFinancier72665990003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAROLITA SHIPPING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Hoegh Autoliners (Uk) Limited
    Young Street
    W8 5EH London
    5
    England
    06. Apr. 2016
    Young Street
    W8 5EH London
    5
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Registrierungsnummer01524900
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CAROLITA SHIPPING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A first priority norwegian ship mortgage
    Erstellt am 05. Okt. 2006
    Geliefert am 23. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel "hoegh treasure" registered with imo number 9184859 and in her equipment and appurtenances and including the proceeds of all insurance sums for the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Commercial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 13. Okt. 2005
    Geliefert am 18. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all policies of insurance in relation to "hual treasure" (the vessel) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the vessel and all moneys payable which arise out of the use or operation of the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Commercial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Ship mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 2005
    Geliefert am 18. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sixty-fourth shares in the vessel "hual carolita". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Commercial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed of general assignment
    Erstellt am 01. Dez. 2003
    Geliefert am 05. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company; carolita shipping limited; allco finance (UK) limited; aus shipping LTD; allocean limited; or leif hoegh & co asa to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right, title and interest, present and future, in, to and under a deed of general assignment dated 20 march 2000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of general assignment between the company, allco finance limited (the "general partner"), allco finance (UK) limited (the "sponsor") and lloyds commercial leasing limited (the "investor") in favour of lloyds tsb bank PLC in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and certain other beneficiaries (the "security trustee")
    Erstellt am 20. März 2000
    Geliefert am 03. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys, liabilities and obligations due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with any documents from time to time designated as "transaction documents" by each of the general partner, the investor, the bank guarantor and uih
    Kurze Angaben
    Right title and interest under a deed of general assignment, a time charter, a guarantee dated 20 march 2000, the benefit of the insurances in respect of the said vessel and any compensation.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Ship mortgage
    Erstellt am 10. Mai 1999
    Geliefert am 18. Mai 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee set forth in the participation agreement and the deed and in order to secure the performance of all monies due or to become due from the company to the chargee thereunder (the amount of principal, interest and all other monies due at any given time being ascertainable by reference to the participation agreement , the deed and/or books of accounts or other accounting records of the bank).
    Kurze Angaben
    All sixty-four sixty fourth shares of the company in the vessel "hual carolita" registered under bahamanian flag at the port of nassau with official number 732202. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture creating a floating charge postponed to all other security interest between carolita shipping limited and lloyds bank PLC
    Erstellt am 04. Sept. 1998
    Geliefert am 22. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies liabilities and obligations due or to become due from or by the company and/or all or any of the security parties (as defined) to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC(As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of general assignment and covenant between the company (as owner), allco finance limited (as general partner), allco finance limited (as sponsor), lloyds commercial leasing limited (as investor) and lloyds bank PLC (as assignee)
    Erstellt am 04. Sept. 1998
    Geliefert am 22. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each a "security party") to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to a). The insurances b). Any requisition compensation and c). All sums of money on or from the date of creation of the charge standing to the credit of an account and all related rights thereto and thereof d). The charterparty the construction supervision agreement, the uih guarantee of charter and secondary put option and all claims rights and remedies of that assignor arising therefrom (inc. All damages and compensation payable) e). The novated shipbuilding contract and the novation agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC(As Security Chargee for Itself and the Beneficiaries )
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0