BROOKHOUSE 2004 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BROOKHOUSE 2004 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03566250 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROOKHOUSE HOLDINGS LIMITED | 23. Juni 2003 | 23. Juni 2003 |
| BROOKHOUSE HOLDINGS PLC | 18. Mai 1998 | 18. Mai 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 035662500003 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2020 bis 31. März 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Nord Aerospace Bidco Limited als Direktor am 02. Feb. 2021 | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 15 Seiten | MA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 15 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Paul Rossiter als Direktor am 02. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher John Morris als Direktor am 02. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neal J Keating als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Kennard Walsh als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Daniel Starr als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 035662500003, erstellt am 02. Feb. 2021 | 10 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, Christopher John | Geschäftsführer | India Mill BB3 1AD Darwen India Mill Business Centre Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 279772890001 | |||||||||
| ROSSITER, Matthew Paul | Geschäftsführer | India Mill BB3 1AD Darwen India Mill Business Centre Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 279773100001 | |||||||||
| NORD AEROSPACE BIDCO LIMITED | Geschäftsführer | 74a Charlotte Street W1T 4QJ London Ariel House |
| 279785870001 | ||||||||||
| MCCAY, Michael | Sekretär | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | 150873130001 | |||||||||||
| THOMAS, Guy | Sekretär | Heathercombe Goodshaw Lane Crawshawbooth BB4 8DJ Rossendale Lancashire | British | 243854970002 | ||||||||||
| TURNER, Peter Graham | Sekretär | Homeacre Loveley Hall Lane Salesbury BB1 9EQ Blackburn Lancashire | British | 4574620002 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| BARNHART, Richard Roman | Geschäftsführer | Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield 1332 Connecticut United States | United States | American | 238701340001 | |||||||||
| DAWSON, Timothy Hugh | Geschäftsführer | St Leonards Close Harrogate HG2 8NU North Yorkshire 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 189597670001 | |||||||||
| DENNINGER, William C | Geschäftsführer | Roxbury Road 06902 Stamford 231 Conneticut Usa | Usa | Usa | 135136300001 | |||||||||
| GARNEAU, Robert Montgomery | Geschäftsführer | 47 Bittersweet Lane South Glastonbury Connecticut 06073 FOREIGN Usa | United States | 48031750001 | ||||||||||
| KEATING, Neal J | Geschäftsführer | 1332 Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield Kaman Corporation Connecticut Usa | United States | American | 131338140004 | |||||||||
| KENYON, Christopher | Geschäftsführer | Ladybridge Lane Heaton BL15DE Bolton Wayside United Kingdom | England | British | 189597660001 | |||||||||
| LAFLEUR, Michael Thomas | Geschäftsführer | India Mill BB3 1AD Darwen Kaman Composites Uk Ltd Lancashire United Kingdom | United States | American | 237419940001 | |||||||||
| MCCAY, Michael John | Geschäftsführer | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | England | British | 27028700002 | |||||||||
| NICHOLS, James | Geschäftsführer | 6 Balterley Court CW2 5SB Balterley Cheshire | England | British | 97001660002 | |||||||||
| RATCLIFFE, Jane Catherine | Geschäftsführer | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | United Kingdom | British | 139843980001 | |||||||||
| STARR, Robert Daniel | Geschäftsführer | Blue Hills Avenue Bloomfield 06002 Connecticut 1332 United States | United States | American | 179471330001 | |||||||||
| STEINER, Gregory Lee | Geschäftsführer | 1332 Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield Kaman Corporation Connecticut Usa | Usa | Usa | 131845020004 | |||||||||
| THOMAS, Guy | Geschäftsführer | Heathercombe Goodshaw Lane Crawshawbooth BB4 8DJ Rossendale Lancashire | England | British | 243854970002 | |||||||||
| TURNER, Barry Frederick | Geschäftsführer | New House Farm Osbaldeston Lane BB2 7LZ Osbaldeston Blackburn | British | 4574630002 | ||||||||||
| TURNER, Peter Graham | Geschäftsführer | Homeacre Loveley Hall Lane Salesbury BB1 9EQ Blackburn Lancashire | British | 4574620002 | ||||||||||
| WALSH, Ian Kennard | Geschäftsführer | BB3 1AD Darwen India Mill Lancashire United Kingdom | United States | American | 275131710001 | |||||||||
| WHEELER, Carl Stephen | Geschäftsführer | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | United Kingdom | British | 148688200001 | |||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BROOKHOUSE 2004 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookhouse Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | BB3 1AD Darwen India Mill Lancashire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BROOKHOUSE 2004 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. Feb. 2021 Geliefert am 10. Feb. 2021 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2004 Geliefert am 20. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0