03566373 LTD
Überblick
| Unternehmensname | 03566373 LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03566373 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 03566373 LTD?
- (7412) /
Wo befindet sich 03566373 LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Freshford House Redcliffe Way BS1 6NL Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 03566373 LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PASSTOR LIMITED | 19. Mai 1998 | 19. Mai 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 03566373 LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 03566373 LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 21 Seiten | WU15 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 19 Seiten | WU07 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 20 Seiten | WU07 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 22 Seiten | WU07 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom One Redcliff Street Bristol BS1 6NP zum Freshford House Redcliffe Way Bristol BS1 6NL am 13. Okt. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:Progress report ends 12/01/2017 | 16 Seiten | LIQ MISC | ||
Erfüllung der Belastung 3 teilweise | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 9 teilweise | 4 Seiten | MR04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP zum One Redcliff Street Bristol BS1 6NP am 03. Feb. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||
legacy | 3 Seiten | AC93 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed target consulting\certificate issued on 18/12/15 | Seiten | CERTNM | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Apr. 2014 | 13 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 12 Seiten | 2.35B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Apr. 2014 | 12 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Okt. 2013 | 10 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Apr. 2013 | 11 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Okt. 2012 | 12 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Okt. 2012 | 11 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 24. Mai 2012 | 22 Seiten | 2.24B | ||
Wer sind die Geschäftsführer von 03566373 LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENNETT, Amanda Louise | Sekretär | Redcliffe Way BS1 6NL Bristol Freshford House | British | 85770530001 | ||||||
| BENNETT, Amanda Louise | Geschäftsführer | Redcliffe Way BS1 6NL Bristol Freshford House | England | British | 85770530001 | |||||
| HARMAN, Mark David | Geschäftsführer | Redcliffe Way BS1 6NL Bristol Freshford House | England | British | 137945300001 | |||||
| LENTHALL, Gavin Antony | Geschäftsführer | Redcliffe Way BS1 6NL Bristol Freshford House | United Kingdom | British | 47377290001 | |||||
| SANDIFORD, Andrew Philip | Geschäftsführer | Redcliffe Way BS1 6NL Bristol Freshford House | England | British | 122009600001 | |||||
| SEELEY, Keith | Geschäftsführer | Redcliffe Way BS1 6NL Bristol Freshford House | United Kingdom | British | 84367450004 | |||||
| COOK, Sarah | Sekretär | 10 Drynham Road BA14 0PE Trowbridge Wiltshire | British | 84682100001 | ||||||
| HARMAN, Mark David | Sekretär | 4 Rode Hill Rode BA11 6PT Frome Windrush Somerset | British | 59169960001 | ||||||
| LENTHALL, Gavin Antony | Sekretär | Flat 1 54 Hampton Park BS6 6LJ Bristol Avon | British | 47377290001 | ||||||
| WALSH, Robert Daniel | Sekretär | Vine Cottage 76 Carlingcott BA2 8AP Peasedown St John Bath | British | 60752980001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ATKINSON, Anthony | Geschäftsführer | 37 Randall Road Chandlers Ford SO53 5AJ Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | 142063890001 | |||||
| GARDNER, John | Geschäftsführer | 7 Meathop Grange Meathop LA11 6RB Grange Over Sands Cumbria | England | British | 103822010001 | |||||
| GRIFFITHS, Martin William | Geschäftsführer | 15 Downs Park East Westbury Park BS6 7QF Bristol | British | 52265300003 | ||||||
| HELLEN, Joanna Elisabeth Alexandra | Geschäftsführer | 7 Surrey Road Bishopston BS7 9DJ Bristol | British | 86789450001 | ||||||
| PALMER, Adrian Russell | Geschäftsführer | 19 Royal Crescent BA1 2LT Bath | British | 101374620002 | ||||||
| ROLFE, Jonathan Sholto | Geschäftsführer | Roseland Close Solsbury Court BA1 7AD Bath 4 Somerset | United Kingdom | British | 141653930001 | |||||
| SKEDD, Alison Jane | Geschäftsführer | Cote House Upper Wraxall SN14 7AG Chippenham Wilts | England | British | 113208220001 | |||||
| SWIFT, Anthony Hugh | Geschäftsführer | Horsecombe Grange Horsecombe Vale BA2 5QR Bath | England | British | 36361530003 | |||||
| WOODCOCK, Thomas | Geschäftsführer | 7 Holcombe Lane Bathampton BA2 6UL Bath | British | 74559910001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat 03566373 LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Juli 2011 Geliefert am 22. Juli 2011 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 04. Apr. 2011 Geliefert am 07. Apr. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £25,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Rent deposit only. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2005 Geliefert am 07. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £626,000 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery,all goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 2005 Geliefert am 09. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Nov. 2002 Geliefert am 07. Nov. 2002 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over deposits | Erstellt am 21. Feb. 2001 Geliefert am 01. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge over any sums deposited in any deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 21. Feb. 2001 Geliefert am 23. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat 03566373 LTD Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0