AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03571109 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AGRA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED | 19. Juni 1998 | 19. Juni 1998 |
| ASHMET LIMITED | 27. Mai 1998 | 27. Mai 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Nov. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Amec Nominees Limited am 27. Mai 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAND, Kim Andrea | Sekretär | Sutton Field Whitegate CW8 2BD Northwich Cherry Trees, Cheshire | British | 141032930001 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Geschäftsführer | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | England | British | 141025870003 | |||||||||
| AMEC NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire |
| 32732300002 | ||||||||||
| DITTMER, Robert | Sekretär | 78 Sunset Way S E Calgary Alberta T2x 3c1 Canada | Canadian | 61292360003 | ||||||||||
| FELLOWES, Colin | Sekretär | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Sekretär | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Sekretär | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||||||
| JAMES, Sean | Sekretär | 4135 Varsity Road Nw Calgary Alberta T3b 2y5 Canada | Canadian | 61292500001 | ||||||||||
| TABERNER, Susan | Sekretär | 9 Hillside BL1 5DT Bolton Lancashire | British | 96933410001 | ||||||||||
| ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||||||
| BARDSLEY, Michael John | Geschäftsführer | 7 Downs End WA16 8BQ Knutsford Cheshire England | British | 34847060001 | ||||||||||
| DITTMER, Robert | Geschäftsführer | 78 Sunset Way S E Calgary Alberta T2x 3c1 Canada | Canadian | 61292360003 | ||||||||||
| GALANGE, Dennis Joseph | Geschäftsführer | 299 Dalewood Drive L67 4P4 Oakville Ontario Canada | Canadian | 72824880001 | ||||||||||
| HOLLAND, Peter James | Geschäftsführer | Woodside House Wynnstay Lane, Marford LL12 8LH Wrexham | Wales | British | 75624260001 | |||||||||
| JAMES, Sean | Geschäftsführer | 4135 Varsity Road Nw Calgary Alberta T3b 2y5 Canada | Canadian | 61292500001 | ||||||||||
| JANSON, Peter S | Geschäftsführer | 27 Dunloe Road Toronto Ontario M4v 2w4 Canada | Canadian | 69670480001 | ||||||||||
| PEARSON, Harold William | Geschäftsführer | 136 Avondale Court L7L2M8 Burlington Ontario Canada | Canadian | 63588330001 | ||||||||||
| TAYLOR, Alexander | Geschäftsführer | 2026 Mississauga Road Mississauga FOREIGN Ontario Canada | Canadian | 31069160001 | ||||||||||
| ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
Hat AMEC CANADA EUROPEAN HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of insurance (the "assignment") | Erstellt am 12. Mai 1999 Geliefert am 26. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Kurze Angaben The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document (the "security document") | Erstellt am 12. Mai 1999 Geliefert am 26. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge and debt assignment (the "share charge") | Erstellt am 12. Mai 1999 Geliefert am 26. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Kurze Angaben First fixed charge all present and future investments (as defined) and dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0