WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03576124 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 93 Queen Street S1 1WF Sheffield South Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WILLIAM COOK BLAIR MACHINE SHOP LIMITED | 29. Okt. 1998 | 29. Okt. 1998 |
| IMCO (1898) LIMITED | 04. Juni 1998 | 04. Juni 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 14 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Aug. 2012 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 93 Queen Street Sheffield South Yorkshire S1 1WF England am 18. Aug. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Parkway Avenue Sheffield S9 4UL am 07. Juli 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. März 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2008 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2006 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 395 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2005 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUGHTON, Michael Barry | Sekretär | 8 The Old Saw Mill Cowling BD22 0JT Keighley West Yorkshire | British | 109567330001 | ||||||
| COOK, Andrew John, Sir | Geschäftsführer | Reduit Le Variouf Forest GY8 0BH Guernsey Channel Islands | England | British | 102659430002 | |||||
| GRAYLEY, Kevin John | Geschäftsführer | Dove Cottage 23 Mill Farm Drive Newmillerdam WF2 6QP Wakefield West Yorkshire | England | British | 43273780002 | |||||
| AUSTIN, John Alan | Sekretär | 1 Hollincross Lane SK13 8JQ Glossop Derbyshire | British | 99402330001 | ||||||
| BARTLE, Thomas | Sekretär | 18 Ringwood Way Hemsworth WF9 4HZ Pontefract West Yorkshire | British | 79918800001 | ||||||
| CALDWELL, John Christopher | Sekretär | 282 Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | British | 83552520001 | ||||||
| COOK, David Laurence | Sekretär | 30 Hargreaves Close Morley LS27 9TE Leeds West Yorkshire | British | 92183980001 | ||||||
| MOORE, Peter John | Sekretär | Flat 3 Osborne Court 154 Osborne Road S11 9BB Sheffield | British | 43273740002 | ||||||
| UPRICHARD, Andrew | Bevollmächtigter Sekretär | 1 Alexandra Road SK17 9NQ Buxton Derbyshire | British | 900006640001 | ||||||
| BARTLE, Thomas | Geschäftsführer | 18 Ringwood Way Hemsworth WF9 4HZ Pontefract West Yorkshire | British | 79918800001 | ||||||
| CALDWELL, John Christopher | Geschäftsführer | 282 Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | England | British | 83552520001 | |||||
| CLARK, Ross Mckenzie | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 15 Hall Farm Grove Hoylandswaine S36 7LJ Barnsley South Yorkshire | British | 900016690001 | ||||||
| DEAN, David James | Geschäftsführer | 15 Tremaine Close Hartside TS27 3LE Hartlepool Teeside | England | British | 90981030001 | |||||
| KITE, Philip John | Geschäftsführer | Garden House Town Farm NE43 7UL Newton Northumberland | United Kingdom | British | 43273920002 | |||||
| MOORE, Peter John | Geschäftsführer | Flat 3 Osborne Court 154 Osborne Road S11 9BB Sheffield | British | 43273740002 | ||||||
| SIMKINS, Angela | Geschäftsführer | Hambleton View Kirby Hill Boroughbridge YO51 9DS York | United Kingdom | British | 60263960001 |
Hat WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 08. Feb. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Juni 2006 Geliefert am 04. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 2004 Geliefert am 27. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 17. Aug. 2004 Geliefert am 26. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Dede of adherence (to a composite guanrantee and debenture date 23 january 1998) | Erstellt am 30. Okt. 1998 Geliefert am 17. Nov. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 30 october 1998 may at any time hereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever by any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0