WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03576124
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WILLIAM COOK BLAIR MACHINE SHOP LIMITED29. Okt. 199829. Okt. 1998
    IMCO (1898) LIMITED04. Juni 199804. Juni 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis27. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    14 Seiten4.72

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Aug. 2011

    LRESEX

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Aug. 2012

    14 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 93 Queen Street Sheffield South Yorkshire S1 1WF England am 18. Aug. 2011

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Parkway Avenue Sheffield S9 4UL am 07. Juli 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 07. Juni 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. März 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2009

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2008

    17 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Re guarnatee / debenture & intercreditior deed 29/01/2008
    RES13

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    8 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    17 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2006

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    7 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2005

    16 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOUGHTON, Michael Barry
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    British109567330001
    COOK, Andrew John, Sir
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    EnglandBritish102659430002
    GRAYLEY, Kevin John
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish43273780002
    AUSTIN, John Alan
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    Sekretär
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    British99402330001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    British79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British83552520001
    COOK, David Laurence
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    British92183980001
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Sekretär
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    British43273740002
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British900006640001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    British79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish83552520001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    British900016690001
    DEAN, David James
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    Geschäftsführer
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    EnglandBritish90981030001
    KITE, Philip John
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    United KingdomBritish43273920002
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Geschäftsführer
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    British43273740002
    SIMKINS, Angela
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    Geschäftsführer
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    United KingdomBritish60263960001

    Hat WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • William Cook Holdings Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Juni 2006
    Geliefert am 04. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Trustees of the Aj Cook Pension Scheme
    Transaktionen
    • 04. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Aug. 2004
    Geliefert am 27. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 27. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Aug. 2004
    Geliefert am 26. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew John Cook Cbe (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Dede of adherence (to a composite guanrantee and debenture date 23 january 1998)
    Erstellt am 30. Okt. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 30 october 1998 may at any time hereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever by any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Hat WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Jan. 2014Aufgelöst am
    05. Aug. 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0