V.V. STOCKTON G.P. LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameV.V. STOCKTON G.P. LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03581559
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von V.V. STOCKTON G.P. LIMITED?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich V.V. STOCKTON G.P. LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von V.V. STOCKTON G.P. LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KNEETRADE LIMITED15. Juni 199815. Juni 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von V.V. STOCKTON G.P. LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für V.V. STOCKTON G.P. LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. März 2010

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 23. März 2009

    LRESSP

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    8 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    13 SeitenAA

    legacy

    10 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    12 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von V.V. STOCKTON G.P. LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Sekretär
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    6118210006
    ANDERSON, William Wallace
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    Geschäftsführer
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    EnglandBritish2894560001
    CARPENTER, Mark Richard Charles
    62 Murray Road
    SW19 4PE Wimbledon
    Geschäftsführer
    62 Murray Road
    SW19 4PE Wimbledon
    EnglandBritish69709970001
    ELY, Roger Benjamin
    53 Five Arches
    Orton Wistow
    PE2 6FQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    53 Five Arches
    Orton Wistow
    PE2 6FQ Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish69707840001
    GEIPEL FABER, Ute
    Robert-Koch Strasse
    Munchen
    80538
    Germany
    Geschäftsführer
    Robert-Koch Strasse
    Munchen
    80538
    Germany
    German66364770002
    JARRETT, Desmond Mason
    19 Hambalt Road
    Clapham
    SW4 9EA London
    Geschäftsführer
    19 Hambalt Road
    Clapham
    SW4 9EA London
    EnglandBritish72779980001
    KRONESTER, Karl Heinz
    Bertelestr 23
    Munich
    FOREIGN 81479
    Germany
    Geschäftsführer
    Bertelestr 23
    Munich
    FOREIGN 81479
    Germany
    German69708410001
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    6118210006
    DAWS, Raymond Kenneth
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    Sekretär
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    British54856640001
    FOX, Ian John
    Flat 6 1 Queens Avenue
    Muswell Hill
    N10 3PE London
    Sekretär
    Flat 6 1 Queens Avenue
    Muswell Hill
    N10 3PE London
    British55591880001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BRIGHT, Keith
    5 Bateman Road
    Croxley Green
    WD3 3BL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Bateman Road
    Croxley Green
    WD3 3BL Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish65764440001
    BUSHNELL, Patrick James
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish26791960001
    BYSH, Rodney Alexander
    Neustaetterstr 4
    80636 Munich
    FOREIGN Germany
    Geschäftsführer
    Neustaetterstr 4
    80636 Munich
    FOREIGN Germany
    British45848330003
    DAWS, Raymond Kenneth
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    British54856640001
    FOX, Ian John
    Flat 6 1 Queens Avenue
    Muswell Hill
    N10 3PE London
    Geschäftsführer
    Flat 6 1 Queens Avenue
    Muswell Hill
    N10 3PE London
    British55591880001
    SMITH, Andrew Richard Ingram
    15 Hurst Farm Road
    RH19 4DQ East Grinstead
    West Sussex
    Geschäftsführer
    15 Hurst Farm Road
    RH19 4DQ East Grinstead
    West Sussex
    British71449570001
    SMITH, Susan Elizabeth
    7 Oakdene Court Lewin Roady
    Streatham
    SW19 6JP London
    Geschäftsführer
    7 Oakdene Court Lewin Roady
    Streatham
    SW19 6JP London
    British59376860002
    UNDERHILL, Anthony Owen
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    British80855550001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    Hat V.V. STOCKTON G.P. LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 2005
    Geliefert am 13. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the north side of corcode way, stockton-on-tees t/no CE124717 and all buildings and other structures from time to time thereon and all fixture (other trade or tenants' fixtures) and all the fixed plant, machinery and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hesssen-Thuringen Girozentrale
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge granted by (1) the general partner (2) V.V. nominees limited (the nominee) and (3) preston farm business park stockton limited (the jersey nominee) in favour of (4) landesbank hessen-thuringen girozentrale (the bank)
    Erstellt am 29. Feb. 2000
    Geliefert am 18. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities on the part of the borrower and/or the mortgagor to the chargee pursuant to the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto together with all moneys, obligations and liabilities on the part of the borrower and/or the mortgagor to the chargee on any account whatsoever together with all expenses, and any interest charged under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land on the north side of concorde way stockton on tees - CE124717 and all buildings and other structures and all fixtures and assigns to the bank all rental income and other income from the property together with the benefit of all warranties - for full details see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thurigen Girozentrale ("the Bank")
    Transaktionen
    • 18. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 27. Aug. 1998
    Geliefert am 09. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from V.V. stockton LP and/or the mortgagor to the chargee pursuant to the terms of any of the finance documents (as defined) and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All the whatsoever and wheresoever present and future. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Account charge and assignment by way of security
    Erstellt am 27. Aug. 1998
    Geliefert am 09. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from V.V. stockton LP and/or the general partner to the chargee pursuant to the terms of any of the finance documents (as defined) and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Aug. 1998
    Geliefert am 09. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from V.V. stockton LP and/or the mortgagor to the chargee in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the north side of concorde way and referred to as preston farm business park stockton-on-tees cleveland t/no: CE124717 with all rentsand other income relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Hat V.V. STOCKTON G.P. LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. März 2009Beginn der Liquidation
    04. Aug. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0