TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03591323 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Tony Wilson Place M15 4FN Manchester England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HURST PUBLISHING HOLDINGS LIMITED | 03. Juli 1998 | 03. Juli 1998 |
| HURST NEWCO 2 LIMITED | 26. Juni 1998 | 26. Juni 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 035913230008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Walker als Geschäftsführer am 22. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 9 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 035913230008, erstellt am 15. Apr. 2015 | 31 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 035913230007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 035913230006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Joanne Walker am 18. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Somerset am 17. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Sean Glithero am 17. März 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Sean Robert Glithero am 17. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT zum 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN am 23. Dez. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tara Collet als Geschäftsführer am 03. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Somerset als Direktor am 25. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 035913230007 | 27 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLITHERO, Sean | Sekretär | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | 159905460001 | |||||||
| GLITHERO, Sean Robert | Geschäftsführer | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 129229070002 | |||||
| SOMERSET, Ian | Geschäftsführer | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 191225040001 | |||||
| BESWITHERICK, David Peter | Sekretär | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | 15959630001 | ||||||
| HODGSON, Simon | Sekretär | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Sekretär | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| JENKIN, Elizabeth | Sekretär | Sundew Close RG40 5YB Wokingham 7 Berkshire United Kingdom | British | 137518870001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Sekretär | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Sekretär | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Sekretär | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | United Kingdom | 155633620001 | ||||||
| PERRISS, Robyn | Sekretär | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Geschäftsführer | Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147214630001 | |||||
| CASTRO, Nicholas | Geschäftsführer | 18 Branscombe Gardens N21 3BN London | England | British | 39006500001 | |||||
| COLLET, Tara | Geschäftsführer | Wing Close SL7 2RA Marlow 2 Bucks United Kingdom | England | British | 160951420001 | |||||
| HODGSON, Simon | Geschäftsführer | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Geschäftsführer | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| LANE, Stephen John Roger | Geschäftsführer | 55 Matlock Road Caversham RG4 7BP Reading Berkshire | England | British | 123670600001 | |||||
| LUFF, Graham Ewart | Geschäftsführer | Willows Westbrook Boxford RG20 8DN Newbury Berkshire | British | 46555440002 | ||||||
| MCCALL, Carolyn Julia | Geschäftsführer | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 39252480010 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Geschäftsführer | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 162220750001 | |||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Geschäftsführer | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | England | United Kingdom | 155633620001 | |||||
| PERRISS, Robyn | Geschäftsführer | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| WALKER, Joanne | Geschäftsführer | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 180119580001 |
Hat TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 15. Apr. 2015 Geliefert am 20. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 26. Feb. 2014 Geliefert am 13. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 26. Feb. 2014 Geliefert am 13. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Global accession deed | Erstellt am 03. Okt. 2003 Geliefert am 10. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Erstellt am 30. Apr. 2003 Geliefert am 19. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in the deposit moneys from time to time standing to the credit of the cash collateral account held with the royal bank of scotland ac no: 20207614 s/c no: 160400. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein | Erstellt am 24. Mai 2000 Geliefert am 08. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Erstellt am 21. Juli 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the deed and/or the investor deed dated 4TH july 1998 | |
Kurze Angaben First fixed charge all the company's right title and interest in and to the deposit monies and the debt represented by the deposit monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0