RO SPENNYMOOR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRO SPENNYMOOR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03599609
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RO SPENNYMOOR LIMITED?

    • (7012) /

    Wo befindet sich RO SPENNYMOOR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RO SPENNYMOOR LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NELSON SPENNYMOOR LIMITED26. März 200426. März 2004
    NELSON SPENNYMORE LIMITED05. März 200405. März 2004
    NELSON CHELTENHAM LIMITED10. Juni 199910. Juni 1999
    SHELFCO (NO.1510) LIMITED17. Juli 199817. Juli 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RO SPENNYMOOR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für RO SPENNYMOOR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Juli 2011

    Kapitalaufstellung am 19. Juli 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Graham St John Rowlandson am 17. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Susan Margaret Younghusband am 17. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für The Finance & Industrial Trust Ltd am 17. Juli 2010

    2 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    12 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    13 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    14 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    15 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    14 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von RO SPENNYMOOR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THE FINANCE & INDUSTRIAL TRUST LTD
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Graham House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Graham House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer79331
    104409340001
    ROWLANDSON, Richard Graham St John
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish3609230001
    YOUNGHUSBAND, Susan Margaret
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish104413240002
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Sekretär
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Sekretär
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    BUDD, Nicholas Peter
    Glynridge
    27 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Glynridge
    27 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish43335810002
    BUDD, Tony William Peter
    Chestnuts 31 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Chestnuts 31 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritish5718200001
    HAMBIDGE, Roger Alan
    Vicarage Farm House
    Churchway Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Vicarage Farm House
    Churchway Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British82434210001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Geschäftsführer
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    44503290001

    Hat RO SPENNYMOOR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 07. Apr. 2004
    Geliefert am 15. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land known as merrington lane industrial estate spennymoor t/ns DU223769 and part of land under t/n DU138502. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2003
    Geliefert am 23. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities due or to become due from nelson investments limited (the "borrower") to the chargee (the "holder") on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cnc Properties Limited
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2003
    Geliefert am 17. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 imperial square cheltenham GL50 1QZ F. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party second legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company or nelson property holdings limited (the borrower) to the chargee on any account whatsoever including all monies due under the terms of the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H 22 imperial square cheltenham gloucs t/no.GR170518 together with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery. By way of second fixed legal charge the rental income .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cnc Properties Limited
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party floating charge
    Erstellt am 15. Aug. 2001
    Geliefert am 22. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All or any monies obligations and liabilities due or to become due from nelson property holdings limited (the "borrower") or the company to the chargee on any account whatsoever and other sums incurred by the bank pursuant to the agreement constituted by the acceptance by (inter alia) the borrower of the bank's facility letter dated 26 july 2001
    Kurze Angaben
    By way of floating charge with full title guarantee all the company's undertaking property and other assets whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2001
    Geliefert am 22. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All or any monies obligations and liabilities due or to become due from nelson property holdings limited (the "borrower") or the company to the chargee on any account whatsoever and other sums incurred by the bank pursuant to the agreement constituted by the acceptance by (inter alia) the borrower of the bank's facility letter dated 26 july 2001
    Kurze Angaben
    First fixed legal mortgage over all that f/h property k/a 22 imperial square, cheltenham, GL50 1QZ t/n GR170518 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery now or hereafter thereon belonging to the company and all improvements and additions thereto.. First floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment owned by the company now or from time to time placed on or used in or about the charged property... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge with floating charge (including assignment of rents)
    Erstellt am 21. Mai 1999
    Geliefert am 03. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to clause 2 of the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property - 22 imperial sq,cheltenham; t/no GR170518; all rights,benefits,buildings,fixtures/fittings,fixed plant/machinery thereon; see form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 03. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0