RO SPENNYMOOR LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RO SPENNYMOOR LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03599609 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RO SPENNYMOOR LIMITED?
- (7012) /
Wo befindet sich RO SPENNYMOOR LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Graham House 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RO SPENNYMOOR LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NELSON SPENNYMOOR LIMITED | 26. März 2004 | 26. März 2004 |
| NELSON SPENNYMORE LIMITED | 05. März 2004 | 05. März 2004 |
| NELSON CHELTENHAM LIMITED | 10. Juni 1999 | 10. Juni 1999 |
| SHELFCO (NO.1510) LIMITED | 17. Juli 1998 | 17. Juli 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RO SPENNYMOOR LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RO SPENNYMOOR LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Graham St John Rowlandson am 17. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Susan Margaret Younghusband am 17. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für The Finance & Industrial Trust Ltd am 17. Juli 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RO SPENNYMOOR LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE FINANCE & INDUSTRIAL TRUST LTD | Sekretär | 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Graham House Hertfordshire United Kingdom |
| 104409340001 | ||||||||||
| ROWLANDSON, Richard Graham St John | Geschäftsführer | Graham House 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Hertfordshire | England | British | 3609230001 | |||||||||
| YOUNGHUSBAND, Susan Margaret | Geschäftsführer | Graham House 7 Wyllyotts Place EN6 2JD Potters Bar Hertfordshire | England | British | 104413240002 | |||||||||
| WALKER-ROBSON, Colin Laird | Sekretär | 231 Waldegrave Road Strawberry Hill TW1 4TA Twickenham Middlesex | British | 2667400002 | ||||||||||
| WESTON, Carole Linda | Sekretär | 44 Stratford Road WD17 4NZ Watford | British | 62673550003 | ||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
| BUDD, Nicholas Peter | Geschäftsführer | Glynridge 27 The Avenue KT20 5AY Tadworth Surrey | England | British | 43335810002 | |||||||||
| BUDD, Tony William Peter | Geschäftsführer | Chestnuts 31 The Avenue KT20 5AY Tadworth Surrey | United Kingdom | British | 5718200001 | |||||||||
| HAMBIDGE, Roger Alan | Geschäftsführer | Vicarage Farm House Churchway Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 82434210001 | ||||||||||
| LEVER, Gary Thomas | Geschäftsführer | 20 Richmond Mansions 250 Old Brompton Road SW5 9HN London | United Kingdom | British | 83224530001 | |||||||||
| LOCKER, Robert John | Geschäftsführer | Beukenhof Tite Hill TW20 0NJ Englefield Green Surrey | England | British | 155603490001 | |||||||||
| MAIS, Richard Jeremy Ian | Geschäftsführer | 79 Seal Hollow Road TN13 3RY Sevenoaks Kent | England | British | 1464610001 | |||||||||
| WALKER-ROBSON, Colin Laird | Geschäftsführer | 231 Waldegrave Road Strawberry Hill TW1 4TA Twickenham Middlesex | England | British | 2667400002 | |||||||||
| MIKJON LIMITED | Geschäftsführer | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 44503290001 |
Hat RO SPENNYMOOR LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 07. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land known as merrington lane industrial estate spennymoor t/ns DU223769 and part of land under t/n DU138502. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party debenture | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 23. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities due or to become due from nelson investments limited (the "borrower") to the chargee (the "holder") on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 17. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 22 imperial square cheltenham GL50 1QZ F. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party second legal charge | Erstellt am 15. Aug. 2001 Geliefert am 04. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company or nelson property holdings limited (the borrower) to the chargee on any account whatsoever including all monies due under the terms of the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben F/H 22 imperial square cheltenham gloucs t/no.GR170518 together with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery. By way of second fixed legal charge the rental income .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party floating charge | Erstellt am 15. Aug. 2001 Geliefert am 22. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All or any monies obligations and liabilities due or to become due from nelson property holdings limited (the "borrower") or the company to the chargee on any account whatsoever and other sums incurred by the bank pursuant to the agreement constituted by the acceptance by (inter alia) the borrower of the bank's facility letter dated 26 july 2001 | |
Kurze Angaben By way of floating charge with full title guarantee all the company's undertaking property and other assets whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 15. Aug. 2001 Geliefert am 22. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All or any monies obligations and liabilities due or to become due from nelson property holdings limited (the "borrower") or the company to the chargee on any account whatsoever and other sums incurred by the bank pursuant to the agreement constituted by the acceptance by (inter alia) the borrower of the bank's facility letter dated 26 july 2001 | |
Kurze Angaben First fixed legal mortgage over all that f/h property k/a 22 imperial square, cheltenham, GL50 1QZ t/n GR170518 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery now or hereafter thereon belonging to the company and all improvements and additions thereto.. First floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment owned by the company now or from time to time placed on or used in or about the charged property... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge with floating charge (including assignment of rents) | Erstellt am 21. Mai 1999 Geliefert am 03. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to clause 2 of the charge | |
Kurze Angaben F/Hold property - 22 imperial sq,cheltenham; t/no GR170518; all rights,benefits,buildings,fixtures/fittings,fixed plant/machinery thereon; see form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0