PROTECTAGROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROTECTAGROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03599653
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROTECTAGROUP LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich PROTECTAGROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PROTECTAGROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MOTAQUOTE HOLDINGS LIMITED11. Dez. 200211. Dez. 2002
    FINALROUND LIMITED17. Juli 199817. Juli 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROTECTAGROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROTECTAGROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 15 Canada Square London E14 5GL am 11. März 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 15. Feb. 2019

    LRESSP

    Ernennung von Dean Clarke als Sekretär am 11. Dez. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 11. Dez. 2018

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    4 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 035996530014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 03. Aug. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 03. Aug. 2018

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Antonios Erotocritou als Direktor am 02. März 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 02. März 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Scott Egan als Geschäftsführer am 14. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von PROTECTAGROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARKE, Dean
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    253940010001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomCypriot167795710001
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    BROWN, Ian William
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    British262382040001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249430920001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221973010001
    KIRKNESS, Barrie
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    Sekretär
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    British103733180001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183327890001
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Sekretär
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    British67745500003
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ATTWOOD, Leo Samuel
    127 Kennerleigh Road
    Rumney
    CF3 4BH Cardiff
    Geschäftsführer
    127 Kennerleigh Road
    Rumney
    CF3 4BH Cardiff
    British102933950002
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish125097020001
    BRICE, Richard Ian James
    14 Hensol Villas
    Hensol
    CF72 8JZ Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    14 Hensol Villas
    Hensol
    CF72 8JZ Pontyclun
    Mid Glamorgan
    WalesWelsh120606700001
    BROWN, Ian William
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish262382040001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Geschäftsführer
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritish134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish171398800001
    CHARD, Michael Francis
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    Geschäftsführer
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    UkBritish45725420009
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish170703910001
    HAGGETT, Linda
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    Geschäftsführer
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    United KingdomWelsh137893590001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Geschäftsführer
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish193700560001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    POWELL, Kenneth John
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    WalesBritish27317930001
    RAGAN, Edwin Robert
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    British61072270005
    RAGAN, Kay Elaine
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    British86274390002
    RAGAN, Paul Robert
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish60263070005
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Geschäftsführer
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    British67745500003
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish147194830001
    REES, Paul
    Plot 1 Springfield Gardens
    Hirwaun
    CF44 9PA Aberdare
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Plot 1 Springfield Gardens
    Hirwaun
    CF44 9PA Aberdare
    Mid Glamorgan
    British72333970002
    RIDEWOOD, Gary Spencer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritish112745560001
    RILEY, Dylan James
    14 Three Cliffs Drive
    Southgate
    SA3 2BN Swansea
    Geschäftsführer
    14 Three Cliffs Drive
    Southgate
    SA3 2BN Swansea
    West GlamorganBritish117675190001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROTECTAGROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Protectagroup Holdings Limited
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Eclipse Park
    Kent
    England
    06. Apr. 2016
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Eclipse Park
    Kent
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House Cardiff
    Registrierungsnummer05081105
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat PROTECTAGROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2015
    Geliefert am 22. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 24770055 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Aug. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Mai 2013
    Geliefert am 23. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2477005.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 07. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 06. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 06. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2010
    Geliefert am 18. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Sept. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession
    Erstellt am 04. Juni 2008
    Geliefert am 17. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2006
    Geliefert am 04. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 14 commercial street, pontnewydd, cymbran, gwent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2004
    Geliefert am 21. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 2003
    Geliefert am 17. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 38 hannah street porth rhondda cynon taff.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 2003
    Geliefert am 17. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 76 bute street treorchy rhondda cynon taff.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Jan. 2003
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2002
    Geliefert am 03. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Loan facility agreement
    Erstellt am 03. Aug. 2001
    Geliefert am 11. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Up to £150,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All debts arising from and the goodwill of the business of after the event litigation insurance carried on by the company all book debts computer software intellectual property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Finsure Premium Finance Limited
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 27. März 2008
    • 05. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PROTECTAGROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Feb. 2019Beginn der Liquidation
    27. Juni 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0