BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03606581 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CLINOVIA HOLDINGS LIMITED | 12. Sept. 2003 | 12. Sept. 2003 |
| LVL MEDICAL (UK) LTD | 11. Okt. 2000 | 11. Okt. 2000 |
| CLINOVIA HOLDINGS LIMITED | 30. Juni 1999 | 30. Juni 1999 |
| CAREMARK HOLDINGS LIMITED | 16. Okt. 1998 | 16. Okt. 1998 |
| OVAL (1346) LIMITED | 30. Juli 1998 | 30. Juli 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Tetley Beazley als Geschäftsführer am 19. Mai 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA am 10. Jan. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mahboob Ali Merchant als Geschäftsführer am 10. Dez. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Robert Taylor als Geschäftsführer am 15. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ellerby als Geschäftsführer am 01. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 37 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Sheehy als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Robert Taylor als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Ellerby als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| FLANAGAN, Stephen David | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 117787010001 | |||||
| LOS, Steven Michael | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 116895800001 | |||||
| BRASSINGTON, David John | Sekretär | The Willows 37 New Road AL6 0AQ Welwyn Hertfordshire | British | 94323000001 | ||||||
| LYON, David Oliver | Sekretär | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | British | 51084280003 | ||||||
| WADDELL, Ian Francis | Sekretär | Muirside Glebe Lane Hartley Wintney RG27 8EA Basingstoke Hampshire | British | 28497990001 | ||||||
| OVALSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
| ADLER, Daniel Andrew | Geschäftsführer | 25 Parkside Mill Hill NW7 2LJ London | United Kingdom | British | 153729250001 | |||||
| AYLWIN, Andrew Richard | Geschäftsführer | 138 Trevelyan Road Tooting SW17 9LW London | United Kingdom | British | 124750150001 | |||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| BRASSINGTON, David John | Geschäftsführer | The Willows 37 New Road AL6 0AQ Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 94323000001 | |||||
| BURNS, Robert Ian | Geschäftsführer | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | 36584260002 | |||||
| BUSCOMBE, Philip John | Geschäftsführer | The Ferry House Ferry Lane Goring On Thames RG8 9DX Reading Oxfordshire | England | British | 47503900001 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 40582650004 | |||||
| FLETCHER, David Robert Ross | Geschäftsführer | 140 Station Road AL5 4RH Harpenden Hertfordshire | British | 67346040001 | ||||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||
| KEE, Fergus Alexander | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | Irish | 26911740008 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| LAVOREL, Benjamin | Geschäftsführer | Chemin Du Bois Caluire Et Cuire 69300 France | French | 70949410001 | ||||||
| LAVOREL, Jean-Claude | Geschäftsführer | Chemin Du Bois Caluire Du Bois 69300 France | French | 70900190001 | ||||||
| LAVOREL, Stanislas | Geschäftsführer | Chemin Du Bois Caluire Et Cuire 69300 France | French | 70900270001 | ||||||
| LYON, David Oliver | Geschäftsführer | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | 51084280003 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| METZELER, Severine | Geschäftsführer | 41 Rue Nuzilly Caluire Et Cuire 69300 France | French | 70900340001 | ||||||
| SCOREY, Michael George | Geschäftsführer | 18 Alexander Place SW7 2SF London | United Kingdom | British | 1749220001 | |||||
| SHAW, Joanna Mary | Geschäftsführer | 8 Cowbridge SG14 1PQ Hertford Hertfordshire | British | 92201390001 | ||||||
| SHEEHY, Stuart David | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 123217250001 | |||||
| SPOORS, Mark | Geschäftsführer | 27 Newfield Way Highfield Park AL4 0GB St Albans Hertfordshire | British | 72289290002 | ||||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| WADDELL, Ian Francis | Geschäftsführer | Muirside Glebe Lane Hartley Wintney RG27 8EA Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 28497990001 | |||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 | |||||||
| OVALSEC LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 |
Hat BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Aug. 2003 Geliefert am 29. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 09. Sept. 2002 Geliefert am 17. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 23. Sept. 1998 Geliefert am 02. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BUPA HOME HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0