J. W.FIDLER & SONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ. W.FIDLER & SONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03612475
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J. W.FIDLER & SONS LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich J. W.FIDLER & SONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Dte House
    Hollins Mount
    BL9 8AT Hollins Lane Bury
    Greater Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von J. W.FIDLER & SONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HAMSARD FIVE THOUSAND AND TEN LIMITED10. Aug. 199810. Aug. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J. W.FIDLER & SONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für J. W.FIDLER & SONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    legacy

    1 Seiten287

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 14. Aug. 2006

    2 Seiten1.3

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    15 Seiten1.1

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2004

    20 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    9 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von J. W.FIDLER & SONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARTIN, Peter Douglas
    Skippers
    Newmarket Road
    CB8 8SS Moulton
    Suffolk
    Sekretär
    Skippers
    Newmarket Road
    CB8 8SS Moulton
    Suffolk
    New Zealander36973660001
    KANG, Jatinder Pal
    South View
    5 Martins Field Little Leigh
    CW8 4YB Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    South View
    5 Martins Field Little Leigh
    CW8 4YB Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish99525200001
    KANG, Kulvinderjit
    South View 5 Martins Field
    Little Leigh
    CW8 4YB Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    South View 5 Martins Field
    Little Leigh
    CW8 4YB Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish99525420001
    RADIA, Krishna
    154 Albury Drive
    HA5 3RG Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    154 Albury Drive
    HA5 3RG Pinner
    Middlesex
    British25380110001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Bevollmächtigter Sekretär
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008750001
    LOTAY, Inderjeet
    88 Yeading Avenue
    HA2 9RH Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    88 Yeading Avenue
    HA2 9RH Harrow
    Middlesex
    British62770350001
    RADIA, Krishna
    154 Albury Drive
    HA5 3RG Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    154 Albury Drive
    HA5 3RG Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish25380110001
    HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008740001

    Hat J. W.FIDLER & SONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 12. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 23-27 robert street manchester t/n GM171406.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 16 robert street manchester t/n LA314302.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The l/h property known as land and buildings at carnarvon street robert street pimblett street manchester t/n GM812857.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h property situate at and known as the passage between robert street and pimblett street manchester t/n GM812856.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. März 2002
    Geliefert am 26. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land and premises fronting horton street stockport greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 24. Mai 1999
    Geliefert am 27. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Policy number C148561S with swiss life (UK) PLC on the life of inderjeet lotay and all related rights thereto and thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 24. Mai 1999
    Geliefert am 27. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Policy number C148563S in favour of the company effected with swiss life (UK) PLC on the life of krishna radia and all related rights thereto and thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 15. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company (as defined therein) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent for Itself and Close Brothers Protected Vct PLC)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 15. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as hamsard five thousand and ten limited) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 15. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as hamsard five thousand and ten limited) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at horton street stockport t/no GM35208. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 15. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as hamsard five thousand and ten limited) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    23-27 robert street manchester t/no GM171406. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 15. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as hamsard five thousand and ten limited) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at robert street pimblett street and carnarvon street manchester t/no LA27173 LA204420 LA349936 LA287064. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1999
    Geliefert am 15. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as hamsard five thousand and ten limited) to the chargee on any account whatsoever under the indemnity
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all rights title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat J. W.FIDLER & SONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. März 2006Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    14. Aug. 2006Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Reeves
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    John Malcolm Titley
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount, Hollins Lane
    Bury, Lancashire
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount, Hollins Lane
    Bury, Lancashire
    2
    DatumTyp
    05. März 2012Aufgelöst am
    28. Juni 2006Antragsdatum
    25. Nov. 2011Abschluss der Liquidation
    14. Aug. 2006Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Malcolm Titley
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount, Hollins Lane
    Bury, Lancashire
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount, Hollins Lane
    Bury, Lancashire
    Paul Reeves
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0