AMEY RAILTECH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AMEY RAILTECH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03612744 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AMEY RAILTECH LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich AMEY RAILTECH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AMEY RAILTECH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COLESLAW 393 LIMITED | 10. Aug. 1998 | 10. Aug. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMEY RAILTECH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AMEY RAILTECH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Lee Milner am 09. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Melvyn Ewell am 30. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sherard Secretariat Services Limited am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Webster als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AMEY RAILTECH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| EWELL, Melvyn | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 61515760002 | |||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Geschäftsführer | Springfield Road Millhouses S7 2GH Sheffield 147 Yorkshire | England | British | 133714170002 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 36191090003 | |||||||||
| HUI, Carol | Sekretär | GU8 | British | 72371980001 | ||||||||||
| MANTZ, Ann Elizabeth | Sekretär | 21 Four Wents KT11 2NE Cobham Surrey | British | 37441550001 | ||||||||||
| TETLOW, John Richard | Sekretär | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 68445840001 | ||||||||||
| COLE AND COLE (NOMINEES) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Buxton Court 3 West Way OX2 0SZ Oxford | 900007040001 | |||||||||||
| BROWN, John Malcolm | Geschäftsführer | Applewood Drayton Beauchamp HP22 5LS Aylesbury Buckinghamshire | British | 61802820001 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Geschäftsführer | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Geschäftsführer | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| GORMAN, Timothy Paul | Geschäftsführer | Hoplands Gallants Lane ME15 0JS East Farleigh Kent | United Kingdom | British | 180040410001 | |||||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Geschäftsführer | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||||||
| LEO, Jose | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | 93348510004 | ||||||||||
| LINDSAY, Anthony John Joseph | Geschäftsführer | 25 The Glebe Cumnor OX2 9QA Oxford Oxfordshire | British | 43098260002 | ||||||||||
| MCCORMACK, Gerard Joseph | Geschäftsführer | 16 Rectory Road RG40 1DH Wokingham Berkshire | England | British | 93405490001 | |||||||||
| MILLER, David John | Geschäftsführer | 1 Asmara Road NW2 3SS London | United Kingdom | British | 152304230002 | |||||||||
| MOGG, Charles Michael | Geschäftsführer | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 87961010001 | ||||||||||
| PILBEAM, Michael | Geschäftsführer | Sloping Acre Lockeridge SN8 4ED Marlborough Wiltshire | British | 38883200001 | ||||||||||
| PROSSER, Ian David | Geschäftsführer | 19 Glebe Court Melsonby DL10 5NU Richmond North Yorkshire | British | 75895500001 | ||||||||||
| SNOWDON, John Watson Teasdale | Geschäftsführer | Bylands Elms Road Gravel Hill Chalfont St Peter SL9 9QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 127118170001 | |||||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Geschäftsführer | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 55479560003 | |||||||||
| WEBSTER, Christopher Charles | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 154210550001 | |||||||||
| ZIEVE, Jon Doron | Geschäftsführer | 35 Sedgecombe Avenue Kenton HA3 0HW Harrow Middlesex | Uk | British | 61322030001 | |||||||||
| COLE AND COLE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Buxton Court 3 West Way OX2 0SZ Oxford | 900007030001 |
Hat AMEY RAILTECH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 14. März 2003 Geliefert am 26. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0