PRIORY (SEATON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePRIORY (SEATON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03614143
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PRIORY (SEATON) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen

    Wo befindet sich PRIORY (SEATON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PRIORY (SEATON) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    K & S (330) LIMITED12. Aug. 199812. Aug. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRIORY (SEATON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für PRIORY (SEATON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Sept. 2012

    Kapitalaufstellung am 03. Sept. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    3 SeitenAA

    Ernennung von Nigel Edmund Pacey als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    3 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    3 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    10 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von PRIORY (SEATON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Sekretär
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    PACEY, Nigel Edmund
    Edinburgh Road
    ML12 6AX Biggar
    Springdale
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    Edinburgh Road
    ML12 6AX Biggar
    Springdale
    Lanarkshire
    United KingdomBritish135610270001
    AWG PROPERTY DIRECTOR LIMITED
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambs
    Geschäftsführer
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambs
    103622620001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Sekretär
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar,13 Glen Brae
    FK1 5LH Falkirk
    Sekretär
    Willis Mar,13 Glen Brae
    FK1 5LH Falkirk
    British54477430001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Sekretär
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    K & S SECRETARIES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    900006940001
    BLYTH, Alastair Forbes
    79 Gardiner Road
    Blackhall
    EH4 5SR Edinburgh
    Scotland
    Geschäftsführer
    79 Gardiner Road
    Blackhall
    EH4 5SR Edinburgh
    Scotland
    EnglandBritish67075350002
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Geschäftsführer
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritish109258700001
    DYKE, Oliver Gordon
    Crantock
    Vanity Lane, Oulton
    ST15 8UG Stone
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crantock
    Vanity Lane, Oulton
    ST15 8UG Stone
    Staffordshire
    EnglandBritish67596940001
    GRAY, Thomas
    69 Staward Avenue
    NE25 0JG Seaton Delaval
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    69 Staward Avenue
    NE25 0JG Seaton Delaval
    Tyne & Wear
    British35776910002
    GROAT, Susan Elizabeth
    37/12 Malbet Park
    EH16 6SY Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    37/12 Malbet Park
    EH16 6SY Edinburgh
    Midlothian
    British64895230001
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Geschäftsführer
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    British61660001
    MATHIESON, Alan Geoffrey
    Thorn Cottage Fellside Road
    Whickham
    NE16 4LA Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    Thorn Cottage Fellside Road
    Whickham
    NE16 4LA Newcastle Upon Tyne
    British49119760001
    MINCHELLA, Mario
    1b Front Street
    Cleadon
    SR6 7PG Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1b Front Street
    Cleadon
    SR6 7PG Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish14148390001
    SMITH, Allison
    72 Princes Street
    NE30 2HN North Shields
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    72 Princes Street
    NE30 2HN North Shields
    Tyne & Wear
    British68419600001
    SMITH, Allison
    72 Princes Street
    NE30 2HN North Shields
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    72 Princes Street
    NE30 2HN North Shields
    Tyne & Wear
    British68419600001
    SMITH, Robert
    5 Lydcott
    NE38 8TN Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    5 Lydcott
    NE38 8TN Washington
    Tyne & Wear
    British99483500001
    VENABLES, Aileen Anderson
    36 Corbiehill Road
    EH4 5AS Edinburgh
    Geschäftsführer
    36 Corbiehill Road
    EH4 5AS Edinburgh
    United KingdomBritish85155700001
    K & S DIRECTORS LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    900006930001

    Hat PRIORY (SEATON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1999
    Geliefert am 26. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the shareholders agreement of even date between the company, the chargee and greenable limited
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the east of the A192 road seaton northumberland t/no;-ND78134AND nd 80949 (part) and assignment the benefit of all insurance policies and contract of insurance relating to the property and all other rights relating thereto under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Residential Investments Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1999
    Geliefert am 25. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as east side of the 192 road, seaton delaval northumberland title number 78134 in part nd 80949. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 17. Feb. 1999
    Geliefert am 24. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0