WELDONHOME LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWELDONHOME LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03616445
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WELDONHOME LIMITED?

    • Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen

    Wo befindet sich WELDONHOME LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    47 Butt Road
    Colchester
    CO3 3BZ Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WELDONHOME LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für WELDONHOME LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Aug. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2016

    6 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Aug. 2016 bis 31. Juli 2016

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    6 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 5
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 5
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2013

    3 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 5
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2011

    4 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Lisa Curtis als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von WELDONHOME LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRAZIER, Simon Richard
    Hall Road
    Great Bromley
    Bush Farm
    Essex
    Geschäftsführer
    Hall Road
    Great Bromley
    Bush Farm
    Essex
    United KingdomBritish60282720006
    CURTIS, Lisa Jane
    Hall Road
    Great Bromley
    Bush Farm
    Essex
    Sekretär
    Hall Road
    Great Bromley
    Bush Farm
    Essex
    British60282760005
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WELDONHOME LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Simon Richard Brazier
    Hall Road
    CO7 7TR Great Bromley
    Bush Farm
    Essex
    United Kingdom
    13. Aug. 2016
    Hall Road
    CO7 7TR Great Bromley
    Bush Farm
    Essex
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat WELDONHOME LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 02. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    24 acres of land at bush farm, hall road, great bromley, essex by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 2007
    Geliefert am 01. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Memories, haggars lane, frating, essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2005
    Geliefert am 25. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Harwin, frating road, great bromley, colchester, essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 14. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 acres of land on the east side of hall road great bromley essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2003
    Geliefert am 18. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings adjacent to bush farm house, hall road, gt. Bromley, essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2003
    Geliefert am 18. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land adjacent to 343 point clear road, st. Osyth essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2003
    Geliefert am 29. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land adjoining fen house, ipswich road, brantham, suffolk t/n SK11233. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2002
    Geliefert am 07. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2002
    Geliefert am 14. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage green hedges shop road little bromley maningtree tendring essex t/n-EX610476.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2000
    Geliefert am 04. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £72,000.00 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 65 wilsons lane,marks tey,colchester,essex CO6 1ES.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West Investments PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 2000
    Geliefert am 27. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £103,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Green hedges, shop road, little bromley, maningtree essex CO11 2PZ.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West Investments Limited
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Juli 1999
    Geliefert am 07. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £55000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Drumascamph house chase road west great bromley.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West Investments PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0