OPAL PROPERTY GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOPAL PROPERTY GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03619340
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OPAL PROPERTY GROUP LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich OPAL PROPERTY GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square Spinninfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OPAL PROPERTY GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GEMCON LIMITED20. Aug. 199820. Aug. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPAL PROPERTY GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für OPAL PROPERTY GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Apr. 2019

    13 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Apr. 2018

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Apr. 2017

    24 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Apr. 2016

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Apr. 2015

    15 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert, release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:replacement liquidator
    31 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2015

    19 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:re court order replacement of liq
    36 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. März 2014

    19 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Sept. 2013

    18 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    5 Seiten2.16B

    Geänderte Bescheinigung über die Zusammensetzung des Gläubigerausschusses

    1 Seiten2.26B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    1 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    46 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , C/O the Place, Ducie Street, Manchester, M1 2TP am 03. Apr. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Stephen Bodger als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    27 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von OPAL PROPERTY GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Sekretär
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    BERRY, John Kyle
    Keir Street
    Bridge Of Allan
    FK9 4QJ Stirling
    33
    Stirlingshire
    Geschäftsführer
    Keir Street
    Bridge Of Allan
    FK9 4QJ Stirling
    33
    Stirlingshire
    United KingdomBritish134559790001
    DUNCAN, Gavin Robert
    c/o C/O
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    c/o C/O
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Greater Manchester
    EnglandBritish151512820001
    DWEK, Joseph Claude
    Hill Top
    Hale
    WA15 0NJ Altrincham
    The Coppins 16
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hill Top
    Hale
    WA15 0NJ Altrincham
    The Coppins 16
    Cheshire
    United KingdomBritish140172170001
    HANSON, James Donald
    35-37 Grosvenor Square
    W1K 2HN London
    Flat 22
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    35-37 Grosvenor Square
    W1K 2HN London
    Flat 22
    United Kingdom
    EnglandBritish45201690010
    MELLOR, Craig Allan
    c/o C/O
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    c/o C/O
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Greater Manchester
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BONNEY, Joyce Elizabeth
    40 Hyde Bank Road
    New Mills
    SK22 4NN High Peak
    Derbyshire
    Sekretär
    40 Hyde Bank Road
    New Mills
    SK22 4NN High Peak
    Derbyshire
    British73607970001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BODGER, Stephen Graham
    C/O The Place
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    Geschäftsführer
    C/O The Place
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    EnglandEnglish68326860002
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Geschäftsführer
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat OPAL PROPERTY GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over shares
    Erstellt am 04. Apr. 2012
    Geliefert am 19. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to all the charged securities and all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over shares
    Erstellt am 31. Mai 2011
    Geliefert am 09. Juni 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All difidends all rights monies or property accruing or offered at any tine in relation to such charged security. The inital charged securities. Tradefull limited ordinary shares of £1 each number of shares held 1 issued share capital £1 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 09. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over shares and securities
    Erstellt am 04. Okt. 2010
    Geliefert am 08. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee and the finance parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor with full title guarantee with the intent that the security so constituted shall extend to all beneficial interest of the chargor in the charged property and to any proceeds of sale or other realistion of the charged property or any part of it and as continuing security for the payment and discharge of the secured liabilitites charges by way of first fixed charge the shares and securities and the derivative assets to the security trustee for the benefit of itself and the finance parties.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security assignment
    Erstellt am 17. Mai 2010
    Geliefert am 25. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all right title and interest from time to time in the membership interest together with all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance and Leicester PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over shares
    Erstellt am 01. Okt. 2009
    Geliefert am 20. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All present and future right title and interest in and to the charged securities together with all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Insurance assignment of key-man policy
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 10. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or any affiliates on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The key-man policy: life assured: stuart barries wall, sum insured £3,000,000, policy number 16170162, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over shares
    Erstellt am 02. Okt. 2008
    Geliefert am 08. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from osb limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged securities and all other charged securities and all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 27. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the charged securities being 1 ordinary share of £1 in opal student accommodation limited and by way of all other charged securities not charged by clause 3.2A of the charge see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Austalia Bank Limited A.B.N. 12 004 044 937 and Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank) (Together the Lenders and Each a Lender)
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on shares
    Erstellt am 15. Sept. 2008
    Geliefert am 24. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee the company charges to the lender all securities being all the shares in the borrower of £1 each and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 01. Sept. 2008
    Geliefert am 15. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Entire right, title and interest in and to the shares meaning the original shares together with all other shares in the capital of opal nottingham limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 22. Juli 2008
    Geliefert am 24. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to the shares: shares means the original shares together with all other shares in the capital of the company see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 16. Mai 2008
    Geliefert am 23. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the shares, rights money or property of a capital nature by way of bonus, consolidation, conversion, exchange, option, preference, return of capital or otherwise see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    A charge over shares
    Erstellt am 21. Feb. 2008
    Geliefert am 27. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge its entire right,title and interest in and to the shares,all rights money or property of a capital nature see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on shares
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 09. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The securities and all income derived from the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on shares
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 09. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The securities and all income derived from the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 01. Juni 2007
    Geliefert am 06. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the charged securities and all other charges securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 02. Apr. 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the charged securities and all other charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 22. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether on its own behalf or on behalf of any of the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    One ordinary share of £1 in the issued share capital of opal greenwich 1 limited and all the securities and proceeds of sale, all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited Abn 12 004 044 937 (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 30. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged securities referred to and all other charged securities, together with all related rights and all rights in respect of any charged investments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 31. Aug. 2006
    Geliefert am 09. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its present and future right, title and interest in and to the following assets the charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank) (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on shares
    Erstellt am 09. Aug. 2006
    Geliefert am 22. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from opal (yorkshire) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the shares together with all stocks shares bonds or other securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 01. März 2006
    Geliefert am 03. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its present and future right title and interest in and to the following assets. The charged securities. All other charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited A.B.N 12 004044 937
    Transaktionen
    • 03. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on shares
    Erstellt am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from birmingham one limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    With full title guarantee the securities being the one ordinary share in birmingham one limited and all income and all rights.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurance policy
    Erstellt am 24. Aug. 2005
    Geliefert am 09. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the lender and/or any affiliates on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title and interest present and future in the policy of insurance. Policy being - friends provident life & pensions limited, policy number: 12614484, life assured: stuart barrie wall, sum assured: £3,000,000 and all monies including bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Keyman life policy assignment
    Erstellt am 24. Aug. 2005
    Geliefert am 27. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in the policy being the level term assurance policy over the life of stuart wall with friends provident life and pensions limited for £3,000.000 policy number 12614484. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Otherbeneficiaries
    Transaktionen
    • 27. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat OPAL PROPERTY GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. März 2013Beginn der Verwaltung
    05. März 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praktiker
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Leslie Ross
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    2
    DatumTyp
    05. März 2014Beginn der Liquidation
    04. Okt. 2020Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praktiker
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Leslie Ross
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Vorgeschlagener Liquidator
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Daniel Robert Whiteley Smith
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Vorgeschlagener Liquidator
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Leslie Ross
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    Vorgeschlagener Liquidator
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0