ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03621275 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Composites House Sinclair Close DE75 7SP Heanor Derbyshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINCO 1110 LIMITED | 25. Aug. 1998 | 25. Aug. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 17 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alison Murphy am 01. Nov. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alison Murphy als Geschäftsführer am 01. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Alison Murphy als Direktor am 01. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roy Douglas Smith als Geschäftsführer am 12. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel George Darazsdi als Geschäftsführer am 12. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Alison Murphy als Sekretär am 12. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roy Douglas Smith als Sekretär am 12. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY, Alison | Sekretär | Clarendon Road WD17 1JJ Watford 34 Hertfordshire United Kingdom | 214335080001 | |||||||
| CLEARS, David Shaun | Geschäftsführer | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire | United Kingdom | British | 214322760001 | |||||
| GLENNON, Stephen Matthew | Geschäftsführer | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | England | British | 88291900001 | |||||
| BOWERS, Steven John | Sekretär | Thornbury Cottage Chalkhill Coleshill HP7 0LY Amersham Buckinghamshire | British | 61929330004 | ||||||
| MALITSKIE, Mark | Sekretär | 52 High Street Broughton NN14 1NQ Kettering Northamptonshire | British | 68667640001 | ||||||
| MOORE, Alan Brian | Sekretär | Rowan Cottage Hackney Lane Barlow S18 7TD Sheffield | British | 14081040001 | ||||||
| MOORE, Alan Brian | Sekretär | Rowan Cottage Hackney Lane Barlow S18 7TD Sheffield | British | 14081040001 | ||||||
| SMITH, Roy Douglas | Sekretär | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | 170871450001 | |||||||
| TRESIDDER, Hereward Tolmie | Sekretär | 33 Belle Vue Road DE6 1AT Ashbourne Derbyshire | British | 39200370004 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| BEAUMONT, Richard John Kirby | Geschäftsführer | 10 Milverton Terrace CV32 5BA Leamington Spa Warwickshire | British | 98953190001 | ||||||
| BLATHERWICK, Nigel Ashley | Geschäftsführer | 7 Queen Marys Close NG12 2NR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 118979720001 | |||||
| BOWERS, Steven John | Geschäftsführer | Warwick New Road CV32 5JG Leamington Spa Concorde House Warwickshire | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| DARAZSDI, Daniel George | Geschäftsführer | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire | Usa | American | 195049720001 | |||||
| DEVAULT, Jon | Geschäftsführer | 18415 Azofar Ct San Diego Ca San Diego FOREIGN California 92128 United States Of America | American | 63857020001 | ||||||
| DRILLOCK, David M | Geschäftsführer | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | United States | American | 170878740001 | |||||
| ENGLISH, Peter David | Geschäftsführer | 76 Woodside Wimbledon SW19 7QL London | British | 3355360001 | ||||||
| FORD, Richard Guy | Geschäftsführer | Water Stratford House Water Stratford MK18 5DS Buckingham | British | 1467170002 | ||||||
| GHAVAM SHAHIDI, Ebrahim | Geschäftsführer | 2 St Georges Close Allestree DE22 1JH Derby Derbyshire | United Kingdom | British | 117846410001 | |||||
| MABBITT, Jonathan Peter | Geschäftsführer | Sunset Nether Lane DE56 4AP Hazelwood Derbyshire | England | British | 83707310002 | |||||
| MALITSKIE, Mark | Geschäftsführer | 52 High Street Broughton NN14 1NQ Kettering Northamptonshire | England | British | 68667640001 | |||||
| MOORE, Alan Brian | Geschäftsführer | Rowan Cottage Hackney Lane Barlow S18 7TD Sheffield | British | 14081040001 | ||||||
| MOSS, Andrew Brian | Geschäftsführer | Warwick New Road CV32 5JG Leamington Spa Concorde House Warwickshire | England | British | 161928410001 | |||||
| MOSS, Andrew Brian | Geschäftsführer | Saddlebow Cottage Saddlebow Lane CV35 8PQ Claverdon Warwickshire | England | British | 161928410001 | |||||
| MURPHY, Alison | Geschäftsführer | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire | United Kingdom | British | 111169560001 | |||||
| POTTS, Hugh Adrian | Geschäftsführer | 7921 S Hudson Avenue Tuisa Oklahoma 74136 Usa | Usa | British | 52210510003 | |||||
| ROBERTSON, Douglas Grant | Geschäftsführer | Blackmore Grange Blackmore End WR8 0EE Hanley Swan Worcestershire | England | British | 123487130001 | |||||
| SLOMAN, Roger Mark | Geschäftsführer | 13 Woodside Morley DE7 6DG Ilkeston Derbyshire | British | 8257720002 | ||||||
| SMITH, Roy Douglas | Geschäftsführer | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House Derbyshire England | Usa | Usa | 170877010001 | |||||
| SNOWDON, Clive John | Geschäftsführer | New End Barn Spernall Lane Great Alne B49 6JD Alcester Warwickshire | United Kingdom | British | 32242700001 | |||||
| STREET, Andrew John | Geschäftsführer | Fountain House 13 Main Street Middleton DE4 4LQ Matlock Derbyshire | United Kingdom | British | 36056510008 | |||||
| TRESIDDER, Hereward Tolmie | Geschäftsführer | 33 Belle Vue Road DE6 1AT Ashbourne Derbyshire | England | British | 39200370004 | |||||
| WEIDNER, John Charles | Geschäftsführer | 53505 129th East Avenue Tulsa Oklahoma 74134 Usa | Usa | 74299320001 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umeco Limited | 06. Apr. 2016 | Sinclair Close DE75 7SP Heanor Composites House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 11. Dez. 2009 Geliefert am 30. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997, | Erstellt am 23. Nov. 2006 Geliefert am 29. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997 | Erstellt am 16. Juli 2004 Geliefert am 22. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 31. März 1999 Geliefert am 08. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0