ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03621275
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PINCO 1110 LIMITED25. Aug. 199825. Aug. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2018

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 13/12/2018
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beschlüsse

    Resolutions
    17 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Alison Murphy am 01. Nov. 2017

    1 SeitenCH03

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Alison Murphy als Geschäftsführer am 01. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    3 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Ernennung von Mrs Alison Murphy als Direktor am 01. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Roy Douglas Smith als Geschäftsführer am 12. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Daniel George Darazsdi als Geschäftsführer am 12. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Alison Murphy als Sekretär am 12. Aug. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Roy Douglas Smith als Sekretär am 12. Aug. 2016

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MURPHY, Alison
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    214335080001
    CLEARS, David Shaun
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish214322760001
    GLENNON, Stephen Matthew
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Geschäftsführer
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish88291900001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    British68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Sekretär
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Sekretär
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Sekretär
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    170871450001
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Sekretär
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    British39200370004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    British98953190001
    BLATHERWICK, Nigel Ashley
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish118979720001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmerican195049720001
    DEVAULT, Jon
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    Geschäftsführer
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    American63857020001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Geschäftsführer
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    ENGLISH, Peter David
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    Geschäftsführer
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    British3355360001
    FORD, Richard Guy
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    Geschäftsführer
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    British1467170002
    GHAVAM SHAHIDI, Ebrahim
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish117846410001
    MABBITT, Jonathan Peter
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish83707310002
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Geschäftsführer
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish111169560001
    POTTS, Hugh Adrian
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    Geschäftsführer
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    UsaBritish52210510003
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SLOMAN, Roger Mark
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    British8257720002
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Geschäftsführer
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001
    STREET, Andrew John
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish36056510008
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish39200370004
    WEIDNER, John Charles
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Geschäftsführer
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Usa74299320001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Umeco Limited
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    06. Apr. 2016
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 11. Dez. 2009
    Geliefert am 30. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Erstellt am 23. Nov. 2006
    Geliefert am 29. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Erstellt am 16. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire Enterprise Board (Investments) Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derbyshire County Council
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 08. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0