WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOODHOUSE MENSWEAR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03625742
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Granary Building
    1 Canal Wharf
    LS11 5BB Leeds
    West Yorkshire
    Uk
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Jan. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Scott Keith Carpenter als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Gavin Michael George als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Gavin Michael George als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard Paul als Sekretär

    3 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Baird Group Ltd als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Lucas als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Jan. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2010

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Baird Group Ltd am 27. Aug. 2010

    2 SeitenCH02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GEORGE, Gavin Michael
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    Sekretär
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    British156136260001
    CARPENTER, Scott Keith
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    England
    Geschäftsführer
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    England
    United StatesAmerican145987830001
    GEORGE, Gavin Michael
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    Geschäftsführer
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    United KingdomBritish148227120001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Sekretär
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    British122889900001
    COCKIN, Anna Margaret
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    British95030040001
    PAUL, Richard Neil
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    British43099210003
    SPERRY, Ian Nicholas
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    British106924330002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Geschäftsführer
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    EnglandBritish122889900001
    BRICK, Brian Denis
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish9649690002
    FREEDMAN, Jonathan Sydney
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    British5232410001
    GIPSON, Stephen
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Great BritainBritish98785200001
    HALLETT, Peter John
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish20621770002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JOHNSON, Steven Leslie
    4 The Knoll
    MK16 9NZ Sherington
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    4 The Knoll
    MK16 9NZ Sherington
    Buckinghamshire
    EnglandBritish183186080001
    KEYTE, Nicholas
    14 The Mead
    BR3 5PE Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    14 The Mead
    BR3 5PE Beckenham
    Kent
    British120703170001
    LUCAS, Peter
    The Old Rectory
    Oswaldkirk
    YO62 5XT York
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Oswaldkirk
    YO62 5XT York
    EnglandBritish5858840002
    RICH, Michael John
    St Bees School Lane
    Bricket Wood
    AL2 3XS St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    St Bees School Lane
    Bricket Wood
    AL2 3XS St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish189317060001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    SPERRY, Ian Nicholas
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    British106924330002
    START, Philip Grant
    Flat 20 The Factory
    1 Nile Street
    N1 7LX London
    Geschäftsführer
    Flat 20 The Factory
    1 Nile Street
    N1 7LX London
    United KingdomBritish94418810001
    WOODHOUSE, Anthony John
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    Geschäftsführer
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    United KingdomBritish131678400001
    WRIGHT, Adrian James
    The Copse
    10a Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Copse
    10a Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish89162730002
    YORK, Toby Sebastian
    36 Kempe Road
    NW6 6SJ London
    Geschäftsführer
    36 Kempe Road
    NW6 6SJ London
    British45414810002
    BAIRD GROUP LTD
    1 Canal Wharf
    Holbeck
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    Great Britain
    Geschäftsführer
    1 Canal Wharf
    Holbeck
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    Great Britain
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03625742
    139238960001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2007
    Geliefert am 27. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gresham LLP (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplement deed
    Erstellt am 25. Mai 2006
    Geliefert am 09. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Nov. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of rent deposit
    Erstellt am 20. Apr. 1999
    Geliefert am 22. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two leases dated 23 april 1998 and 26 june 1998
    Kurze Angaben
    The deposit sum £34,375.00.
    Berechtigte Personen
    • St Christopher's Place Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. März 1999
    Geliefert am 27. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In respect of the property charged the net proceeds of sale up to £100,000 and 25% of any net proceeds of sale in excess of £100,000 and the due and punctual performance of all the company's obligations to the chargee under an agreement dated 4TH september 1998
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the ground floor shop national house 60-66 wardour street london W1.
    Berechtigte Personen
    • Woodhouse Limited
    Transaktionen
    • 27. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1998
    Geliefert am 22. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1998
    Geliefert am 22. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Speciality Retail Group PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Sept. 1998
    Geliefert am 24. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The "agreed price" (as deined in the agreement of even date) and all monies due or to become due from the company to the chargee under the agreement in relation to the property (as defined)
    Kurze Angaben
    The ground floor shop, national house 60-66 wardour street london W1.
    Berechtigte Personen
    • Woodhouse Limited (In Administrative Receivership) Acting by Lee Manning and Gary Peter Squires of Bulcher Phillips (the Administrative Receivers)
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0