WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03625742 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Granary Building 1 Canal Wharf LS11 5BB Leeds West Yorkshire Uk |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Jan. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Scott Keith Carpenter als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Gavin Michael George als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gavin Michael George als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Paul als Sekretär | 3 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Baird Group Ltd als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Lucas als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Jan. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Baird Group Ltd am 27. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, Gavin Michael | Sekretär | Stratton Street W1J 8LQ London 15 | British | 156136260001 | ||||||||||
| CARPENTER, Scott Keith | Geschäftsführer | Stratton Street W1J 8LQ London 15 England | United States | American | 145987830001 | |||||||||
| GEORGE, Gavin Michael | Geschäftsführer | Stratton Street W1J 8LQ London 15 | United Kingdom | British | 148227120001 | |||||||||
| BRICK, Alexander Paul | Sekretär | 12 The Bishops Avenue N2 0AN London | British | 122889900001 | ||||||||||
| COCKIN, Anna Margaret | Sekretär | 16 Manor House Estate HA7 4BH Stanmore Middlesex | British | 95030040001 | ||||||||||
| PAUL, Richard Neil | Sekretär | 21 Almsford Avenue HG2 8HD Harrogate North Yorkshire | British | 43099210003 | ||||||||||
| SPERRY, Ian Nicholas | Sekretär | 8 St. Thomas Place Wheathampstead AL4 8BG St. Albans Hertfordshire | British | 106924330002 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| BRICK, Alexander Paul | Geschäftsführer | 12 The Bishops Avenue N2 0AN London | England | British | 122889900001 | |||||||||
| BRICK, Brian Denis | Geschäftsführer | 28 Aylmer Drive HA7 3EG Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 9649690002 | |||||||||
| FREEDMAN, Jonathan Sydney | Geschäftsführer | 9 Eastglade HA5 3AN Pinner Middlesex | British | 5232410001 | ||||||||||
| GIPSON, Stephen | Geschäftsführer | The Engine House 2 Leigh Court Barns WR6 5LB Leigh Worcestershire | Great Britain | British | 98785200001 | |||||||||
| HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Goldfields Glenhill Farm Glendon Road NN14 1QE Kettering Northamptonshire | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||||||
| HICK, Paul Arney | Geschäftsführer | Millcourt Mill Road SL7 1QB Marlow Buckinghamshire | England | British | 47699120005 | |||||||||
| JOHNSON, Steven Leslie | Geschäftsführer | 4 The Knoll MK16 9NZ Sherington Buckinghamshire | England | British | 183186080001 | |||||||||
| KEYTE, Nicholas | Geschäftsführer | 14 The Mead BR3 5PE Beckenham Kent | British | 120703170001 | ||||||||||
| LUCAS, Peter | Geschäftsführer | The Old Rectory Oswaldkirk YO62 5XT York | England | British | 5858840002 | |||||||||
| RICH, Michael John | Geschäftsführer | St Bees School Lane Bricket Wood AL2 3XS St Albans Hertfordshire | England | British | 189317060001 | |||||||||
| RIVERS, Paul Edward | Geschäftsführer | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | England | British | 62321110002 | |||||||||
| SPERRY, Ian Nicholas | Geschäftsführer | 8 St. Thomas Place Wheathampstead AL4 8BG St. Albans Hertfordshire | British | 106924330002 | ||||||||||
| START, Philip Grant | Geschäftsführer | Flat 20 The Factory 1 Nile Street N1 7LX London | United Kingdom | British | 94418810001 | |||||||||
| WOODHOUSE, Anthony John | Geschäftsführer | Groesfaen Road Peterston-Super-Ely CF5 6NE Cardiff Elm House | United Kingdom | British | 131678400001 | |||||||||
| WRIGHT, Adrian James | Geschäftsführer | The Copse 10a Copsem Lane KT10 9EU Esher Surrey | United Kingdom | British | 89162730002 | |||||||||
| YORK, Toby Sebastian | Geschäftsführer | 36 Kempe Road NW6 6SJ London | British | 45414810002 | ||||||||||
| BAIRD GROUP LTD | Geschäftsführer | 1 Canal Wharf Holbeck LS11 5BB Leeds Granary Building West Yorkshire Great Britain |
| 139238960001 | ||||||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Hat WOODHOUSE MENSWEAR LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2007 Geliefert am 27. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplement deed | Erstellt am 25. Mai 2006 Geliefert am 09. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Nov. 2005 Geliefert am 13. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit | Erstellt am 20. Apr. 1999 Geliefert am 22. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two leases dated 23 april 1998 and 26 june 1998 | |
Kurze Angaben The deposit sum £34,375.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. März 1999 Geliefert am 27. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In respect of the property charged the net proceeds of sale up to £100,000 and 25% of any net proceeds of sale in excess of £100,000 and the due and punctual performance of all the company's obligations to the chargee under an agreement dated 4TH september 1998 | |
Kurze Angaben Legal mortgage over the ground floor shop national house 60-66 wardour street london W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1998 Geliefert am 22. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1998 Geliefert am 22. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Sept. 1998 Geliefert am 24. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The "agreed price" (as deined in the agreement of even date) and all monies due or to become due from the company to the chargee under the agreement in relation to the property (as defined) | |
Kurze Angaben The ground floor shop, national house 60-66 wardour street london W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0