ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD

ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03630364
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KETECH 2AS LTD22. Mai 200822. Mai 2008
    2AS' LIMITED11. Sept. 199811. Sept. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    22 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Apr. 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Okt. 2013

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Juni 2013

    19 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    36 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    9 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the George Business Centre Christchurch Road New Milton Hampshire BH25 6QJ* am 09. Jan. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Okt. 2012

    Kapitalaufstellung am 04. Okt. 2012

    • Kapital: GBP 80
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2011

    13 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2010

    14 SeitenAA

    legacy

    11 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed ketech 2AS LTD\certificate issued on 11/06/10
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name11. Juni 2010

    Beschluss zur Änderung der Firma am 04. Juni 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RICHARDS, Karen Louise
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    Sekretär
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    British151271280001
    RICHARDS, Andrew Jonathon
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    Geschäftsführer
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    United KingdomBritishDirector134634200001
    RICHARDS, Karen Louise
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    Geschäftsführer
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    United KingdomBritishFinance Director135121780001
    TARRANT, Justin James
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    Geschäftsführer
    Cornhill
    EC3V 3BT London
    32
    United KingdomBritishSenior Project Manager127281230001
    BAWDEN, Graham
    85 Bamford Road
    MK42 0NH Bedford
    Sekretär
    85 Bamford Road
    MK42 0NH Bedford
    BritishAccountant92492170001
    BERG, Steven Andrew
    Boundary Road
    West Bridgford
    NG2 7BZ Nottingham
    22
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Boundary Road
    West Bridgford
    NG2 7BZ Nottingham
    22
    Nottinghamshire
    BritishDirector133872030001
    CHICK, Lesley Anne
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    Bevollmächtigter Sekretär
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    British900008230001
    HOOLEY, Alan Harold
    Lane Cove 198 Clevedon Road
    Tickenham
    BS21 6RT Clevedon
    Avon
    Sekretär
    Lane Cove 198 Clevedon Road
    Tickenham
    BS21 6RT Clevedon
    Avon
    BritishEngineer60428300001
    REDDINGS COMPANY SECRETARY LIMITED
    Apple Garth Oakridge Lane
    Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Somerset
    Sekretär
    Apple Garth Oakridge Lane
    Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Somerset
    56868420002
    BATTERSBEE, Paul Alan
    Victoria Road
    Bulwark
    NP16 5QW Chepstow
    43
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    Victoria Road
    Bulwark
    NP16 5QW Chepstow
    43
    Monmouthshire
    BritishM.D134988060001
    BAWDEN, Graham
    85 Bamford Road
    MK42 0NH Bedford
    Geschäftsführer
    85 Bamford Road
    MK42 0NH Bedford
    BritainBritishAccountant92492170001
    BENNETT, Alan Frank
    Treetops
    Cottons Lane Ashton-Under-Hill
    WR1 6SS Evesham
    Worcs
    Geschäftsführer
    Treetops
    Cottons Lane Ashton-Under-Hill
    WR1 6SS Evesham
    Worcs
    BritishSales Manager34232600001
    BERG, Steven Andrew
    Boundary Road
    West Bridgford
    NG2 7BZ Nottingham
    22
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Boundary Road
    West Bridgford
    NG2 7BZ Nottingham
    22
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector133872030001
    HOOLEY, Alan Harold
    Lane Cove 198 Clevedon Road
    Tickenham
    BS21 6RT Clevedon
    Avon
    Geschäftsführer
    Lane Cove 198 Clevedon Road
    Tickenham
    BS21 6RT Clevedon
    Avon
    BritishEngineer60428300001
    KEARNEY, John Edward
    112 Village Rd
    MK43 8HU Bromham
    The Old Vicarage
    Bedfordshire
    Uk
    Geschäftsführer
    112 Village Rd
    MK43 8HU Bromham
    The Old Vicarage
    Bedfordshire
    Uk
    BritishDirector77583110002
    REDDING, Diana Elizabeth
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    EnglandBritish900004650001

    Hat ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2011
    Geliefert am 04. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of them by any group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Palatine Private Equity LLP (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 06. Mai 2010
    Geliefert am 14. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Accession deed
    Erstellt am 06. Mai 2010
    Geliefert am 12. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Richards and Karen Richards (As Bare Trustees for and on Behalf of Each of Connor Richards, Kieran Richards and Liam Richards)
    Transaktionen
    • 12. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Accession deed
    Erstellt am 06. Mai 2010
    Geliefert am 12. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Richards
    Transaktionen
    • 12. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Accession deed
    Erstellt am 06. Mai 2010
    Geliefert am 12. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Zeus Private Equity LLP (The Security Trustee) on Behalf of the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Accession deed
    Erstellt am 06. Mai 2010
    Geliefert am 12. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Zeus Private Equity LLP (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 12. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge, all real property, all licences, the proceeds of sale, all computers, vehicles, benefit of all contracts, all securities, all non-vesting domestic debts, all non-vesting export debts, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Centric Spv 1 Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 07. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all real property all licences to enter upon the proceeds of sale of all real property all computers vehicles office equipment and the benefit of all contracts licences and warranties relating to the same all securities rights all rights which a security obligor may have at any time against any clearance all securities all intellectual property the benefit of all licences all of the goodwill and uncalled capital floating charge all present future assets and undertaking heritable property and all other property assets in scotland.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 07. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Provident Capital Indemnity Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 02. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 23. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Okt. 1998
    Geliefert am 27. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ELECTRA-NET INTEGRATED CONTROLS LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Dez. 2012Beginn der Verwaltung
    11. Juni 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Francis Gavin Savage
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Hampshire
    Praktiker
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Hampshire
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0