NUMBER ELEVEN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNUMBER ELEVEN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03634473
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NUMBER ELEVEN LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Palladium House
    1 - 4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPEED 7297 LIMITED18. Sept. 199818. Sept. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 26. Sept. 2018

    • Kapital: GBP 100
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Withdrawal of a person with significant control statement on 21. März 2018

    2 SeitenPSC09

    Notification of The Cadogan Debenture Company Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Dez. 2016

    8 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 06. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 500,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 500,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Dez. 2013

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Dez. 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 21. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 500,000
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 18 Cadogan Gardens London SW3 2RP England* am 21. Nov. 2013

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Lora Evans am 18. Sept. 2013

    2 SeitenCH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2012 bis 30. Dez. 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GODDARD, Paul
    1 - 4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    Sekretär
    1 - 4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    177590270001
    EVANS, Lora
    1 - 4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    Geschäftsführer
    1 - 4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    Palladium House
    England
    United KingdomBritish177588890001
    BOTTOMLEY, John Michael
    Apple Garth
    Hook Road Rotherwick
    RG27 9BY Hook
    Hampshire
    Sekretär
    Apple Garth
    Hook Road Rotherwick
    RG27 9BY Hook
    Hampshire
    British4250040006
    EVANS, Lora
    28d Bassett Road
    Ladbroke Grove
    W10 6JJ London
    Sekretär
    28d Bassett Road
    Ladbroke Grove
    W10 6JJ London
    Other118949840001
    LOUTIT, Paul Morris
    Cadogan Gardens
    SW3 2RP London
    18
    Sekretär
    Cadogan Gardens
    SW3 2RP London
    18
    British166565210001
    VULANHOLM LIMITED
    11 Cadogan Gardens
    SW3 2RJ London
    Sekretär
    11 Cadogan Gardens
    SW3 2RJ London
    36471830001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CHANDE, Manish Jayantilal
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    42
    Geschäftsführer
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    42
    United KingdomBritish83291490002
    COLLINS, Marie Laure Helene
    9 Heathview Gardens
    SW15 3SZ London
    Geschäftsführer
    9 Heathview Gardens
    SW15 3SZ London
    British64443640003
    DAVIES, Barnett David
    Holme Cottage 1 Hilltop Avenue
    SK8 7HN Cheadle Hulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Holme Cottage 1 Hilltop Avenue
    SK8 7HN Cheadle Hulme
    Cheshire
    British123120450001
    DAVIES, Gloria Leah
    Holme Cottage 1 Hilltop Avenue
    SK8 7HN Cheadle Hulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Holme Cottage 1 Hilltop Avenue
    SK8 7HN Cheadle Hulme
    Cheshire
    British123120230001
    DAVIES, Paul
    No 5 Avenue Princess Grace
    98000 Monaco
    Apt A34
    Monaco
    Geschäftsführer
    No 5 Avenue Princess Grace
    98000 Monaco
    Apt A34
    Monaco
    MonacoBritish118555790004
    EMSON, Colin Jack
    Shotters Farm
    GU34 3RJ Alton
    Hants
    Geschäftsführer
    Shotters Farm
    GU34 3RJ Alton
    Hants
    United KingdomBritish112674450001
    FARRELL, John Kevin
    26 Alma Square
    NW8 9PY London
    Geschäftsführer
    26 Alma Square
    NW8 9PY London
    EnglandBritish42388910001
    FRESSON, Mark Adrian
    Flat 5
    8 Ormonde Gate
    SW3 4EU London
    Geschäftsführer
    Flat 5
    8 Ormonde Gate
    SW3 4EU London
    United KingdomBritish5777960001
    FRESSON, Michael John
    11 Cadogan Gardens
    SW3 2RJ London
    Geschäftsführer
    11 Cadogan Gardens
    SW3 2RJ London
    British13382990001
    GRANT, Richard John
    Cadogan Gardens
    SW3 2RP London
    18
    Geschäftsführer
    Cadogan Gardens
    SW3 2RP London
    18
    United KingdomBritish39270780001
    MYERS, Martin Trevor
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    Geschäftsführer
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    EnglandBritish35819830001
    PILBROW, Nicholas David
    Flat 5 139 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    Geschäftsführer
    Flat 5 139 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    United KingdomBritish79033130004
    SEABORN, Hugh Richard
    Cadogan Gardens
    SW3 2RP London
    18
    Geschäftsführer
    Cadogan Gardens
    SW3 2RP London
    18
    United KingdomBritish135346630001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    The Cadogan Debenture Company Limited
    W1G 8LN London
    40 Welbeck Street
    06. Apr. 2016
    W1G 8LN London
    40 Welbeck Street
    Nein
    RechtsformLimited Company By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageUk
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer05687776
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für NUMBER ELEVEN LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    18. Sept. 201621. März 2018Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen gibt, hat diese jedoch nicht identifiziert.

    Hat NUMBER ELEVEN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 16. Apr. 2007
    Geliefert am 18. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 2007
    Geliefert am 18. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7-13 (odd) cadogan gardens london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 06. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee Under the Trust Deed)
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H properties k/a 7 to 13 (odd numbers) cadogan gardens, london, t/no NGL345754 and 164 to 170 (even numbers) pavilion road, london t/no BGL40394. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sterling Trust Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H properties k/a 7 to 13 (odd numbers) cadogan gardens, london t/no NGL345754 and 164 to 170 (even numbers) pavilion road, london t/no BGL40394. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mountgrange Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H properties k/a 7 to 13 (odd numbers) cadogan gardens, london t/no NGL345754 and 164 to 170 (even numbers) pavilion road, london t/no BGL40394. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Galenote Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2005
    Geliefert am 30. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 19. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The debt now or hereafter owing to the mortgagor by the mortgagee on the account with the mortgagor now numbered 6010-107835-100 and any account for the time being replacing such account and all interest now or hereafter accruing thereon including interest compunted and treated as principal.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 19. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property being 164,166,168 and 170 pavillion road london SW1 t/no;-NGL345754 and goodwill of the business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 1999
    Geliefert am 18. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Maclew Investments Limited
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 1999
    Geliefert am 21. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0