NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03641392 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
- Tätigkeit von Sportvereinen (93120) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 17 Fitzroy Street Newmarket CB8 0JW Suffolk |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DRIVESCRIPT LIMITED | 30. Sept. 1998 | 30. Sept. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Sept. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Sept. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Sept. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Cessation of John Saville as a person with significant control on 18. Aug. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Samuel Gurney Sheppard as a person with significant control on 12. Mai 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2024 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Thomas Edward Marriott als Direktor am 06. Juni 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Notification of Thomas Edward Marriott as a person with significant control on 06. Juni 2023 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stuart Leslie Arrandale als Geschäftsführer am 30. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Cessation of Stuart Leslie Arrandale as a person with significant control on 30. Mai 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Notification of John Logan Montgomery Crawford as a person with significant control on 12. Aug. 2020 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Ernennung von Mr John Logan Montgomery Crawford als Direktor am 12. Aug. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Saville als Geschäftsführer am 18. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ian David Lindsay als Geschäftsführer am 12. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Cessation of Ian David Lindsay as a person with significant control on 12. Aug. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Samuel Gurney Sheppard als Geschäftsführer am 12. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAWFORD, John Logan Montgomery | Geschäftsführer | Fitzroy Street CB8 0JW Newmarket 32 England | England | British | 66647610003 | |||||
| JOHNSEN, Hugo Anthony | Geschäftsführer | Blooms Hall Lane Stanstead CO10 9AY Sudbury Coppins House England | England | British | 169243160001 | |||||
| MARRIOTT, Thomas Edward | Geschäftsführer | Lords Lane Ousden CB8 8TX Newmarket Littly Wood England | England | British | 37489840005 | |||||
| BURNETT, John Geoffrey Robert Wildman | Sekretär | 92 Station Road CB24 5HG Willingham Cambridgeshire | British | 36253690004 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ARRANDALE, Stuart Leslie | Geschäftsführer | St. Andrews Road CB4 1DL Cambridge 52 United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | 158784690001 | |||||
| BURNETT, John Geoffrey Robert Wildman | Geschäftsführer | 92 Station Road CB24 5HG Willingham Cambridgeshire | United Kingdom | British | 36253690004 | |||||
| DUNN, Hazel Anne | Geschäftsführer | Vicarage Road Great Hockham IP24 1PE Thetford Brambles Norfolk England | United Kingdom | United Kingdom | 161526260001 | |||||
| DUNN, Hazel Anne | Geschäftsführer | Vicarage Road Great Hockham IP24 1PE Thetford Brambles Norfolk United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | 161526260001 | |||||
| DUNN, Richard John Harris | Geschäftsführer | School Lane Barley SG8 8JZ Royston School House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 8680040002 | |||||
| HOLLINGSWORTH, John Christopher | Geschäftsführer | Clopton Hall Wickhambrook CB8 8PQ Newmarket Suffolk | England | British | 33353790001 | |||||
| LINDSAY, Ian David, Dr | Geschäftsführer | 6b Station Road CB7 4BS Ely Hickling House England | United Kingdom | United Kingdom | 180367260001 | |||||
| RICHARDSON, Jeremy Whichcote Phillips | Geschäftsführer | The Street Kirtling CB8 9PB Newmarket The Old School Suffolk England | United Kingdom | Uk | 161501640001 | |||||
| RICHARDSON, Jeremy Whichcote Phillips | Geschäftsführer | The Street Kirtling CB8 9PB Newmarket The Old School Suffolk United Kingdom | United Kingdom | Uk | 161501640001 | |||||
| RILEY, Alexander | Geschäftsführer | St Michaels Mount Longstanton CB4 5EZ Cambridge | United Kingdom | British | 21458570004 | |||||
| SAVILLE, John Raymond | Geschäftsführer | Swan Lane Exning CB8 7EN Newmarket Gable Cottage England | England | British | 248063490001 | |||||
| SHEPPARD, Samuel Gurney | Geschäftsführer | Great Thurlow CB9 7LE Haverhill The Old Vicarage Great Britain | United Kingdom | United Kingdom | 191817970001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NEWMARKET & SUFFOLK REAL TENNIS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Thomas Edward Marriott | 06. Juni 2023 | Lords Lane Ousden CB8 8TX Newmarket Littly Wood England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John Logan Montgomery Crawford | 12. Aug. 2020 | Fitzroy Street CB8 0JW Newmarket 32 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John Saville | 23. Mai 2018 | Swan Lane Exning CB8 7EN Newmarket Gable Cottage England | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Hugo Anthony Johnsen | 23. Mai 2018 | Blooms Hall Lane Stanstead CO10 9AY Sudbury Coppins House England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Stuart Leslie Arrandale | |||