OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03641508 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED?
- (6523) /
- (7487) /
Wo befindet sich OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Grant Thornton Uk Llp 101 Cambridge Science Park Milton Road CB4 0FY Cambridge Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MORTGAGE PROCESSING SERVICES LIMITED | 01. Okt. 1998 | 01. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 1 Seiten | 4.43 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Byron House Cambridge Business Park Cowley Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0WZ am 01. Juli 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 1 Seiten | COCOMP | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 23 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMPSON, Alan Trevor | Geschäftsführer | 1 Butchers Close Vinager Hill, Alconbury Weston PE28 4JE Huntingdon Cambridgeshire | British | Director | 125364840001 | |||||
BECKER, Victoria Ann Louise | Sekretär | The Angel Inn Angel Street GU28 0BG Petworth West Sussex | British | 60464150001 | ||||||
HODGES, Nigel Ian | Sekretär | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | Company Director | 75692570001 | |||||
SEYMOUR, Melanie Jane | Sekretär | Amesbury Claverhambury Road Galley Hill EN9 2BL Waltham Abbey Essex | British | 50139720001 | ||||||
SINGH, Harpal | Sekretär | 23 Baden Road GU2 6NZ Guildford Surrey | British | Financial Consultant | 65408600001 | |||||
BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Pembroke House 7 Brunswick Square BS2 8PE Bristol Avon | 900001040001 | |||||||
BRIGHT, Matthew Charles Ritson | Geschäftsführer | 16 Ormonde Rise IG9 5QQ Buckhurst Hill Essex | British | Company Director | 47908600001 | |||||
LEVEY, David Thomas | Geschäftsführer | 16 North Park Chalfont St. Peter SL9 8JW Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Company Director | 41780970003 | |||||
PALMER, Richard Hugh Joseph | Geschäftsführer | 21 Strathmore Road PO12 1JR Gosport Hampshire | England | British | Company Director | 58312850001 | ||||
SEYMOUR, Andrew John | Geschäftsführer | Amesbury Claverhambury Road Galley Hill EN9 2BL Waltham Abbey Essex | England | British | Mortgage Broker | 112854100001 | ||||
SEYMOUR, Melanie Jane | Geschäftsführer | Amesbury Claverhambury Road Galley Hill EN9 2BL Waltham Abbey Essex | England | British | Company Director | 50139720001 | ||||
SINGH, Harpal | Geschäftsführer | 23 Baden Road GU2 9NZ Guildford Surrey | British | Co Director | 65408600001 | |||||
SINGH, Harpal | Geschäftsführer | 23 Baden Road GU2 6NZ Guildford Surrey | British | Financial Consultant | 65408600001 | |||||
SPARKES, Alan John | Geschäftsführer | 361 Guildford Road Bisley GU24 9AB Woking Surrey | Uk | British | Publican | 78182100004 | ||||
WEBSTER, Sidney Richard | Geschäftsführer | 29 Deal Avenue BN25 3LH Seaford East Sussex | British | Retired | 67900510002 | |||||
WEBSTER, Tony Richard | Geschäftsführer | 2 Downs Road BN25 4QL Seaford East Sussex | British | Company Director | 60464140002 | |||||
WEBSTER, Tony Richard | Geschäftsführer | 2 Downs Road BN25 4QL Seaford East Sussex | British | Regional Mortgage Manager | 60464140002 |
Hat OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Apr. 2007 Geliefert am 01. Mai 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 21. März 2003 Geliefert am 28. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 70108464. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 17. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company,formerly known as mortgage processing services limited,to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 03. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat OPTOMA BROKER SOLUTIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0