ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03641677 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
- Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HAMSARD TWO THOUSAND AND FIVE LIMITED | 01. Okt. 1998 | 01. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Anthony Kempson als Geschäftsführer am 08. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Enza Motors Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Roy Charles Reed as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Brian Anthony Kempson as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Jan. 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Thomas Stead als Geschäftsführer am 30. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Peter Jones als Sekretär am 30. Juni 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Thomas Stead als Sekretär am 30. Juni 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Clifford Fox als Geschäftsführer am 25. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Michael Peter | Sekretär | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | 200992400001 | |||||||
JONES, Michael Peter | Geschäftsführer | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | England | British | Finance Director | 140687070001 | ||||
REED, Roy Charles | Geschäftsführer | 207 Clee Road DN35 9HU Cleethorpes South Humberside | England | British | Director | 29128410001 | ||||
BARRETT, Nigel John | Sekretär | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | British | 15118100001 | ||||||
BARRETT, Nigel John | Sekretär | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | British | 15118100001 | ||||||
SMITH, Gerry Vincent | Sekretär | The Cart Hovel Lowes Lane, Swarkestone DE73 7GQ Derby Derbyshire | British | Managing Director | 161300420001 | |||||
STEAD, John Thomas | Sekretär | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | 167999050001 | |||||||
BARRETT, Nigel John | Geschäftsführer | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15118100001 | ||||
BROWN, Alec Charles | Geschäftsführer | 10 Newquay Court CW12 3BQ Congleton Cheshire | British | Company Director | 17378650001 | |||||
ELGAR PARSONS, Russell | Geschäftsführer | Longhill Lane Audlem CW3 0HU Crewe Yew Tree Cottage England | England | British | Sales & Marketing Director | 124265650002 | ||||
FOX, Steven Clifford | Geschäftsführer | The Hawthorn West End LN1 2XY Ingham Lincolnshire | England | British | Sales Director | 125294270001 | ||||
GOSLING, Richard Neil | Geschäftsführer | Mistal Loft Vicarage Lane CW11 4TB Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | Director | 114025020001 | ||||
HEWITT, Alan | Geschäftsführer | 9 Mardale Court CW4 7JP Holmes Chapel Cheshire | U K | British | Sales Director | 97253550001 | ||||
KEMPSON, Brian Anthony | Geschäftsführer | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | England | British | Managing Director | 156744840002 | ||||
ROBERTS, David Lloyd | Geschäftsführer | 209 Liverpool Road Cadishead M44 5BZ Manchester Lancashire | England | British | Company Director | 29618790001 | ||||
ROSS, John Allan | Geschäftsführer | Millbeck House Gill Lane Rawdon LS19 7DG Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 43839050001 | ||||
SMITH, Gerry Vincent | Geschäftsführer | The Cart Hovel Lowes Lane, Swarkestone DE73 7GQ Derby Derbyshire | England | British | Managing Director | 161300420001 | ||||
STEAD, John Thomas | Geschäftsführer | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Finance Director | 65971430001 | ||||
HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Devonshire Square EC2M 4YH London | 900008740001 | |||||||
HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Devonshire Square EC2M 4YH London | 900008750001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Brian Anthony Kempson | 06. Apr. 2016 | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Roy Charles Reed | 06. Apr. 2016 | The Enza Building Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington Cheshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Enza Motors Limited | 06. Apr. 2016 | Leacroft Road Birchwood WA3 6NN Warrington Enza Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ENZA'S TRUCK WORLD LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 02. Aug. 2006 Geliefert am 10. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 14. Dez. 1999 Geliefert am 30. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge over stock | Erstellt am 27. Jan. 1999 Geliefert am 30. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first floating charge all the stocks of new and used motor vehicles of the company together with all guarantees and warranties relating thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0