RIDHAM 1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RIDHAM 1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03641695 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIDHAM 1 LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich RIDHAM 1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RIDHAM 1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| REFAL 543 LIMITED | 01. Okt. 1998 | 01. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIDHAM 1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RIDHAM 1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Paul Woods am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Nicholas Howard White am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Alan Turner am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Ian Paul Woods am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 2 Seiten | AA | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004 | 8 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von RIDHAM 1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODS, Ian Paul | Sekretär | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | British | 3535740003 | ||||||
| SIMKIN, Richard William | Geschäftsführer | 14 Little Plucketts Way IG9 5QU Buckhurst Hill Essex | England | British | 13432460001 | |||||
| TURNER, Nigel Alan, Mr. | Geschäftsführer | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | England | British | 71592210007 | |||||
| WHITE, Andrew Nicholas Howard | Geschäftsführer | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | United Kingdom | British | 99292200003 | |||||
| WOODS, Ian Paul | Geschäftsführer | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | England | British | 3535740003 | |||||
| BOND, Christopher Joseph | Sekretär | 22 George Street MK17 9PY Woburn Bedfordshire | British | 169680930001 | ||||||
| FEATHERSTONE, Derek William | Sekretär | 21 The Strand Walmer CT14 7DY Deal Kent | British | 38485580002 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Sekretär | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| SANDARS, Paul Francis | Sekretär | 5 Crescent Road SW20 8EY London | British | 60469150001 | ||||||
| ARDERN, Derrick | Geschäftsführer | Twyvidales 85 Eythrope Road HP17 8PH Stone Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 44478670001 | |||||
| BOND, Christopher Joseph | Geschäftsführer | 22 George Street MK17 9PY Woburn Bedfordshire | England | British | 169680930001 | |||||
| BYRNE, James Anthony John | Geschäftsführer | 4 Blythe Way B91 3EY Solihull West Midlands | British | 83499160001 | ||||||
| DUNCOMBE, Roger John | Geschäftsführer | Croft House 16 Faircross Way AL1 4SD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 20158760001 | |||||
| GILMAN, Thomas George | Geschäftsführer | 70 High Street Clifford LS23 6HJ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 103084110001 | |||||
| LAMBERT, James Paul | Geschäftsführer | 2 Portman Avenue East Sheen SW14 8NX London | United Kingdom | British | 103062380001 | |||||
| SANDARS, George Russell | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 5 Crescent Road SW20 8EY London | British | 900007300001 |
Hat RIDHAM 1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Erstellt am 29. Juli 2004 Geliefert am 12. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property 4 and 6 cavendish place london t/n NGL734622 by way of fixed charge all interests in the new property or the proceeds of sale, the benefit of all options easements agreements for lease and other agreements, all plant and machinery and all rights and interests of the company under all agreements for purchase maintenance or use of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Apr. 2002 Geliefert am 22. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent or to each other beneficiary (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0