QOIN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameQOIN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03642323
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von QOIN LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich QOIN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von QOIN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SHELFCO (NO.1558) LIMITED01. Okt. 199801. Okt. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QOIN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für QOIN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 036423230014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 036423230015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Angus Alexander Dodd als Geschäftsführer am 07. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    16 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 03. Jan. 2019

    • Kapital: GBP 100
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share premium 18/12/2018
    RES13

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    17 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2018

    • Kapital: GBP 100
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Change of details for Quintain Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2017

    2 SeitenPSC05

    Änderung der Details des Sekretärs für Frances Victoria Heazell am 01. Dez. 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Michael Ben Jenkins am 01. Dez. 2017

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von QOIN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215876390001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish267205160001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Sekretär
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Sekretär
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Sekretär
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175340700001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Sekretär
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Geschäftsführer
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Geschäftsführer
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Geschäftsführer
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Geschäftsführer
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Geschäftsführer
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish42858810002
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QOIN LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUnited Kingdom
    Registrierungsnummer2694983
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat QOIN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2017
    Geliefert am 09. Nov. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Homes and Communities Agency
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Jan. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2016
    Geliefert am 15. Nov. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The mortgaged property being land lying to the north of swallowdale lane, hemel hempstead industrial estate registered with title number HD283992. Please refer to the instrument for further details.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Jan. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge security agreement
    Erstellt am 14. März 2008
    Geliefert am 17. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 17. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 04. Feb. 2008
    Geliefert am 15. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security agreement
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 07. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security agreement
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 01. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Okt. 2007
    Geliefert am 25. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 20. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements by way of a first floating charge all assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Lender)
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 20. Juli 2004
    Geliefert am 23. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Facility Agent) as Agent and Trustee Forthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 23. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Aug. 2002
    Geliefert am 19. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company and each borrower to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) plot 10,avenue west,newhouse park industrial estate,chepstow; WA779501; (ii) unit 1 doncaster carr industrial estate,doncaster,south yorkshire; SYK362728; (iii) 83 fountain st,manchester M2 2EE; GM165159 plus three other properties listed; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture dated 1ST october 1999 between the chargor and the agent
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 06. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 78A maxed road, hemel hempstead t/no: HD308280. The freehold property known as 9 swallowdale lane, hemel hempstead t/no: 306178 for futher details of other properties please see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 08. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H property k/a trafalgar house richmond avenue reading; l/h property k/a norwich union house, 12 bedford street exeter; f/h property k/a queens house queen street exeter t/nos: BK144207 DN327748 DN71889. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch (The "Agent")
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Scottish assignation in security intimated 6 april 1999 and dated
    Erstellt am 18. März 1999
    Geliefert am 23. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent,and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to each finance party (as defined) under each finance document (as defined) except for any obligation which,if it were so included would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    The whole right title inrerest and benefit of the chargor in and to the general account,the rent account and the substitution account together with:- all balances at any time during the subsistence of the charge.any agreements or instruments entered into in the constitution of the rights and obligations of the chargor.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch (The Agent)
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Feb. 1999
    Geliefert am 17. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each finance party under each finance document on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische-Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation in security intimated 3RD february 1999 and executed
    Erstellt am 19. Jan. 1999
    Geliefert am 06. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future liabilities whether actual or contingent, and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to bayerische hypo-und vereinsbank aktiengesellschaft as agent for itself and the banks (as defined in the agreement) under each finance document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985 ("the secured liabilities")
    Kurze Angaben
    Assigns to the bank its right title interest and benefit in and to the general account, the rent account and the subsititution account together with:- (I) all balances at any time during the subsistence of the charge standing to the credit of the general account, the rent account and the substitution account; (ii) any agreements (whether oral written or implied) or instruments entered into in the constitution of the rights and obligations of the assignor and the account bank in relation to the general account, the rent account and the substitution account;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaftas Agent for Itself and the Banks (As Defined in the Agreement)
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0