QOIN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QOIN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03642323 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QOIN LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich QOIN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QOIN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHELFCO (NO.1558) LIMITED | 01. Okt. 1998 | 01. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QOIN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für QOIN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 036423230014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 036423230015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angus Alexander Dodd als Geschäftsführer am 07. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Jan. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for Quintain Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Frances Victoria Heazell am 01. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr. Michael Ben Jenkins am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QOIN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215876390001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 267205160001 | |||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Sekretär | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Sekretär | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Sekretär | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Sekretär | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175340700001 | |||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Sekretär | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| E P S SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Geschäftsführer | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Geschäftsführer | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Geschäftsführer | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Geschäftsführer | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Geschäftsführer | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| RILEY, Michael Edward | Geschäftsführer | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Geschäftsführer | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Geschäftsführer | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Geschäftsführer | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 | |||||
| MIKJON LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 900004920001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QOIN LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintain Limited | 06. Apr. 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat QOIN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2017 Geliefert am 09. Nov. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 15. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The mortgaged property being land lying to the north of swallowdale lane, hemel hempstead industrial estate registered with title number HD283992. Please refer to the instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enth ält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge security agreement | Erstellt am 14. März 2008 Geliefert am 17. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 04. Feb. 2008 Geliefert am 15. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 07. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 01. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 22. Okt. 2007 Geliefert am 25. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 20. Juli 2004 Geliefert am 28. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company assigns all of its rights under any hedging arrangements by way of a first floating charge all assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 20. Juli 2004 Geliefert am 23. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 06. Aug. 2002 Geliefert am 19. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company and each borrower to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (I) plot 10,avenue west,newhouse park industrial estate,chepstow; WA779501; (ii) unit 1 doncaster carr industrial estate,doncaster,south yorkshire; SYK362728; (iii) 83 fountain st,manchester M2 2EE; GM165159 plus three other properties listed; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture dated 1ST october 1999 between the chargor and the agent | Erstellt am 01. Okt. 1999 Geliefert am 06. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben The freehold property known as 78A maxed road, hemel hempstead t/no: HD308280. The freehold property known as 9 swallowdale lane, hemel hempstead t/no: 306178 for futher details of other properties please see form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 31. März 1999 Geliefert am 08. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben F/H property k/a trafalgar house richmond avenue reading; l/h property k/a norwich union house, 12 bedford street exeter; f/h property k/a queens house queen street exeter t/nos: BK144207 DN327748 DN71889. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Scottish assignation in security intimated 6 april 1999 and dated | Erstellt am 18. März 1999 Geliefert am 23. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent,and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to each finance party (as defined) under each finance document (as defined) except for any obligation which,if it were so included would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben The whole right title inrerest and benefit of the chargor in and to the general account,the rent account and the substitution account together with:- all balances at any time during the subsistence of the charge.any agreements or instruments entered into in the constitution of the rights and obligations of the chargor.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Feb. 1999 Geliefert am 17. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each finance party under each finance document on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation in security intimated 3RD february 1999 and executed | Erstellt am 19. Jan. 1999 Geliefert am 06. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future liabilities whether actual or contingent, and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to bayerische hypo-und vereinsbank aktiengesellschaft as agent for itself and the banks (as defined in the agreement) under each finance document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985 ("the secured liabilities") | |
Kurze Angaben Assigns to the bank its right title interest and benefit in and to the general account, the rent account and the subsititution account together with:- (I) all balances at any time during the subsistence of the charge standing to the credit of the general account, the rent account and the substitution account; (ii) any agreements (whether oral written or implied) or instruments entered into in the constitution of the rights and obligations of the assignor and the account bank in relation to the general account, the rent account and the substitution account;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0