THISTLEHAVEN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THISTLEHAVEN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03649488 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THISTLEHAVEN LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich THISTLEHAVEN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THISTLEHAVEN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THISTLEHAVEN PLC | 14. Okt. 1998 | 14. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THISTLEHAVEN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THISTLEHAVEN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Yves Emile Pierre Belegaud als Direktor am 17. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Guerric Ballu as a person with significant control on 17. Dez. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Guerric Ballu als Geschäftsführer am 17. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Emmanuel Julien Perrousset als Sekretär am 30. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Thorington Jones als Sekretär am 30. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gary Thorington Jones als Sekretär am 24. März 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Semmens als Sekretär am 23. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2016 bis 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Helen Semmens als Sekretär am 01. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Wood als Sekretär am 31. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Wood als Geschäftsführer am 01. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THISTLEHAVEN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERROUSSET, Emmanuel Julien | Sekretär | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | 240709190001 | |||||||
| BALLU, Marc | Geschäftsführer | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | French | 174120160002 | |||||
| BELEGAUD, Yves Emile Pierre | Geschäftsführer | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | France | French | 265689980001 | |||||
| JONES, Gary Thorington | Sekretär | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | 207074080001 | |||||||
| POTTER, Donald Stanley | Sekretär | Crispins 64 The Avenue Worminghall HP18 9LE Aylesbury Buckinghamshire | British | 14077190001 | ||||||
| SEMMENS, Helen | Sekretär | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | 199904380001 | |||||||
| WOOD, Martin | Sekretär | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | 153429110001 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| ALGAR, David Stanley | Geschäftsführer | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 104137450004 | |||||
| BALLU, Guerric | Geschäftsführer | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | France | French | 80574650002 | |||||
| CHARLTON, Peter John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||
| CODLING, David Fletcher | Geschäftsführer | Bowers Farm Magpie Lane HP7 0LU Coleshill Amersham Buckinghamshire | British | 14064770002 | ||||||
| DUMMETT, Robin Piers | Geschäftsführer | 36 Burton Road KT2 5TF Kingston Surrey | British | 104469810001 | ||||||
| FOBEL, Anthony Peter | Geschäftsführer | 15 Hamilton Gardens NW8 9PU London | British | 71917500002 | ||||||
| GALLICO, Timothy Huish | Geschäftsführer | Strand WC2R 0AG London 111 | United Kingdom | British | 117068840001 | |||||
| HALL, Stephen John | Geschäftsführer | Horton Hill Horton BS37 6QP Bristol 1 Adringal Cottages | England | British | 147526740001 | |||||
| HOOPER, Robin Peveril | Geschäftsführer | Strand WC2R 0AG London 111 | England | British | 97001520003 | |||||
| LAFFIN, Simon Timothy | Geschäftsführer | The Whins Lawfords Hill Road GU3 3QB Worplesdon Surrey | England | British | 34427940002 | |||||
| MACKENZIE, Alexander Donald | Geschäftsführer | Shalden Lodge Shalden Lane Shalden GU34 4DU Alton Hampshire | United Kingdom | British | 105120270001 | |||||
| POTTER, Donald Stanley | Geschäftsführer | Crispins 64 The Avenue Worminghall HP18 9LE Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 14077190001 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| WOOD, Martin Richard | Geschäftsführer | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 152495780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THISTLEHAVEN LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Guerric Ballu | 06. Apr. 2016 | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | Ja |
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: France | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Marc Ballu | 06. Apr. 2016 | C/O Hozelock Ltd, Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield West Midlands | Nein |
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat THISTLEHAVEN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 15. März 2010 Geliefert am 24. März 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Keyman insurance assignment | Erstellt am 05. Mai 1999 Geliefert am 13. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined in the credit agreement) including the assignment | |
Kurze Angaben The assignors interest in and to the life policy no 3437926 (see form 395 for full details) and all moneys which are assured pursuant to the policy and all moneys which may become payable thereafter including without limitation the benefit of any claim or action against the insurers of the policy by the assignor arising by reason of or in connection with the policy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Feb. 1999 Geliefert am 23. Feb. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties or any of them under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0