CHICHESTER HEALTH PLC
Überblick
| Unternehmensname | CHICHESTER HEALTH PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 03649544 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHICHESTER HEALTH PLC?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CHICHESTER HEALTH PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7th Floor 21 Lombard Street EC3V 9AH London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHICHESTER HEALTH PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INVESTORS FINANCE COMPANY PLC | 23. Feb. 1999 | 23. Feb. 1999 |
| THISTLEFLEET LIMITED | 14. Okt. 1998 | 14. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHICHESTER HEALTH PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHICHESTER HEALTH PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carl Steven Baldry als Geschäftsführer am 15. Jan. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ United Kingdom zum 7th Floor 21 Lombard Street London EC3V 9AH am 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Capita Trust Company Limited am 16. März 2018 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Steven Baldry am 27. Feb. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Imagile Secretariat Services Limited als Sekretär am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Benedict Symes als Sekretär am 01. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Capita Trust Company Limited am 06. Nov. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Capita Trust Corporate Services Limited am 06. Nov. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Change of details for Chichester Health (Holdings) Limited as a person with significant control on 04. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Victoria House Victoria Road Chelmsford Essex CM1 1JR zum Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ am 04. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Capita Trust Company Limited am 13. Okt. 2016 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Steven Baldry am 31. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susan Elizabeth Lawrence als Geschäftsführer am 31. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHICHESTER HEALTH PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAGILE SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom |
| 170409540002 | ||||||||||
| LINK CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | The Registry 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham Kent | 114688040004 | |||||||||||
| LINK CORPORATE TRUSTEES (UK) LIMITED | Geschäftsführer | 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham The Registry Kent United Kingdom | 82708370021 | |||||||||||
| SYMES, Thomas Benedict | Sekretär | Victoria Road Chelmsford CM1 1JR Essex Victoria House England And Wales United Kingdom | British | 3032460002 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
| BALDRY, Carl Steven | Geschäftsführer | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 199816750001 | |||||||||
| CHARLTON, Peter John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||||||
| FINNEY, David Roger | Geschäftsführer | 31 Water Mill Way Sutton At Hone DA4 9BB Dartford Kent | British | 18277980003 | ||||||||||
| GOWER, Adrian Walton | Geschäftsführer | 3 Windmill Road TW8 0QD Brentford Middlesex | British | 101422170001 | ||||||||||
| HILLS, Peter Michael | Geschäftsführer | 66 Hartslock Drive Thamesmead SE2 9UU London | British | 48947040001 | ||||||||||
| HILLS, Peter Michael | Geschäftsführer | 66 Hartslock Drive Thamesmead SE2 9UU London | British | 48947040001 | ||||||||||
| LAWRENCE, Susan Elizabeth | Geschäftsführer | 18 King William Street EC4N 7HE London 7th Floor,Phoenix House Uk | United Kingdom | British | 149065930001 | |||||||||
| NEEDHAM, Bryan Donald | Geschäftsführer | Riverside Cottage Zephon Common GU51 5SX Crookham Village Fleet Hampshire | England | British | 38629530001 | |||||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHICHESTER HEALTH PLC?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Exchange Trust Company Limited | 06. Apr. 2016 | 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham The Registry Kent United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Chichester Health (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHICHESTER HEALTH PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Hedging security deed between the company (the "issuer") royal exchange trustee nominees limited (the "security trustee") financial security assurance (U.K.) limited ("fsa") salomon brothers international limited ("sbil") and norwich union public/private partnership fund (acting by its general partner mill group (gp) limited) (the "fund") (the "deed") | Erstellt am 23. Mai 2001 Geliefert am 08. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In respect of the security trustee in its capacity as such all monies, debts and liabilities due or to become due from the issuer under or in connection with the hedging security deed; in respect of fsa all obligations of the issuer to fsa under the issuer finance documents (as defined) in respect of the relevant bonds (as defined) including without limitation the obligations of the issuer under clauses 4.9 and 4.10 of the framework collateral deed (as defined) and all monies debts and liabilities due or to become due from the issuer to fsa under or in connection with the issuer insurance and indemnity agreement (as defined) in so far as it relates to the relevant bonds, but for the avoidance of doubt, not in respect of any such obligations relating to any bonds relating to a project if the conditions precedent set out in clause 3.4 of the framework collateral deed have been satisfied in relation to such project; and in respect of sbil or the fund, as the case may be all monies debts and liabilities due or to become due from the issuer to sbil under or in connection with the tripartite agreement and clauses 5 and 6 of the guaranteed returns contract (all as defined) (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben The assets comprising the portfolio from time to time (if any) and all sums derived therefrom and all the issuer's rights attaching to or relating to the portfolio and all sums derived therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 29. Aug. 2000 Geliefert am 12. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag To the extent that they are primary obligations of the obligor, each of the secured issuer liabilities; and/or the obligation of the obligor arising under the security agreement to pay on a full indemnity basis all sums referred to in clause 14 (as defined therein) of the security agreement and all other sums under or in connection with the security agreement (as defined therein) | |
Kurze Angaben Assigns the collateral (as defined therein). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Hedging security deed between the company (the "issuer") royal exchange trustee nominees limited (the "security trustee") financial security assurance (U.K.) limited ("fsa") and J.henry schroder & co. Limited ("jhs") (the "hedging security deed") | Erstellt am 24. Juni 1999 Geliefert am 07. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag (The "security trustee") in its capacity as such under or in connection with the hedging security deed; in respect of fsa all obligations of the issuer to fsa under the issuer finance documents (as defined) in respect of the relevant bonds (as defined) including without limitation the obligations of the issuer under clauses 4.9 and 4.10 of the framework collateral deed (as defined) and all monies debts and liabilities due or to become due from the issuer to fsa under or in connection with the issuer insurance and indemnity agreement (as defined) in so far as it relates to the relevant bonds; in respect of jhs all monies debts and liabilities due or to become due from the issuer to jhs under or in connection with any tripartite agreement clauses 5 and 6 of the guaranteed returns contract or clause 3 and 4 of the master swap agreement (all as defined) (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben The assets comprising the portfolio from time to time (if any) and all sums derived therefrom and all the issuer's rights attaching to or relating to the portfolio and all sums derived therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 1999 Geliefert am 25. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of royal exchange trustee nominees limited (the "security trustee") all monies and liabilities which may be due owing or payable by the issuer to fsa on any account whatsoever or in respect of the issuer secured trustees' amounts in any currency actually or contingently , as principal or as surety on any amount whatsoever (the "secured issuer liabilities") pursuant to the issuer finance documents (as defined) together with on a full indemnity basis, the renumeration which shall form part of the secured issuer liabilities and accordingly be secured on the charged assets due to the receiver pursuant to clause 8.5 of the debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CHICHESTER HEALTH PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0