KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED

KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03654031
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Astute House
    Wilmslow Road
    SK9 3HP Wilmslow
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KELVIC HOLDINGS LIMITED21. Okt. 199821. Okt. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2018

    17 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    20 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2017

    17 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2016

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2015

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2014

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2013

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 26. Jan. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2012

    8 Seiten4.68

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Coach House Tyersal Hall Farm Tyersal Lane Bradford West Yorkshire BD4 0RE* am 20. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    15 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2011

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Feb. 2010

    Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Simon Baker am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Stewart Blackburn am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAKER, Simon
    57 Wesley Street
    WF5 8EU Ossett
    West Yorkshire
    Sekretär
    57 Wesley Street
    WF5 8EU Ossett
    West Yorkshire
    British116601610001
    BLACKBURN, Robert Stewart
    270a Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    270a Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish109418670001
    BLACKBURN, Louise Claire
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    Sekretär
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    British107374150001
    NELSON, Mark Richard
    21 The Lilacs
    Guiseley
    LS20 9ER Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    21 The Lilacs
    Guiseley
    LS20 9ER Leeds
    West Yorkshire
    British107373910001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BLACKBURN, Louise Claire
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    British107374150001
    BLACKBURN, Robert Stewart
    3 Moorside Street Abb Scott Lane
    Low Moor
    BD12 0EN Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Moorside Street Abb Scott Lane
    Low Moor
    BD12 0EN Bradford
    West Yorkshire
    British61676090001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Hat KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 2009
    Geliefert am 10. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Phoenix park sports ground, daleside road, pudsey, t/no WYK298998.
    Berechtigte Personen
    • Harpmanor Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 217. Feb. 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 217. Feb. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Jan. 2009
    Geliefert am 10. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h land k/a land and buildings at phoenix park, sports complex, daleside road, thornbury, bradford west yorkshire WYK298998 together with floating security its undertaking and all its property assets and rights whatsoever see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Harpmanor Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £64,750 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 8-16 (even) nelson street and 27-29 (odd) wellington road, dewsbury and back nelson street, dewsbury.
    Berechtigte Personen
    • Oakapple Estates Limited
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. März 2008
    Geliefert am 28. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 8-16 (even) nelson street dewsbury & 27-29 (odd) wellington road dewsbury t/no's WYK627704 & WYK258522 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2008
    Geliefert am 15. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £600,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    Church house 12A north parade bradford.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Sept. 2007
    Geliefert am 15. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 8 henry street, huddersfield. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Aug. 2007
    Geliefert am 25. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 10 well lane batley t/no WYK501239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 120 deal burn road low moor bradford west yorkshire t/n WYK772732. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2006
    Geliefert am 08. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 2006
    Geliefert am 17. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 120 dealburn road, low moor, bradford.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Juni 2006
    Geliefert am 09. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 120 dealburn road low moor bradford t/n WYK772732. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Cheval Property Developments Limited
    Transaktionen
    • 09. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2011Beginn der Liquidation
    07. Dez. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Beesley
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    Praktiker
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    Tracy M Clowry
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    Praktiker
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    Gareth Hunt
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    Praktiker
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Beesley
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    Receiver Manager
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0