NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03655685 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o NHP MANAGEMENT LTD Liberty House 222 Regent Street W1B 5TR London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LEGISLATOR 1400 LIMITED | 26. Okt. 1998 | 26. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Hanover Square London W1S 1JF am 15. Jan. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Hugh Thompson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Grant als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 42 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANG, Lily | Sekretär | Calbourne Road SW12 8LW London 9 United Kingdom | Malaysian | 140239060001 | ||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Geschäftsführer | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||
| THOMPSON, Paul Hugh | Geschäftsführer | St. Johns Road TN13 3LR Sevenoaks 15b Kent United Kingdom | England | British | 100977220001 | |||||
| FLETCHER, Rachel Elizabeth | Sekretär | Flat 1 Basement 269 Magdalen Road Earlsfield SW18 3NZ London | British | 106745220001 | ||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Sekretär | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||
| KAUL, Sheila | Sekretär | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | 70194600001 | ||||||
| KILMARTIN, Adrian Robert | Sekretär | Church Farm Acton Turville GL9 1HD Badminton South Gloucestershire | British | 11660010001 | ||||||
| MIDMER, Richard Neil | Sekretär | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | 110640170001 | ||||||
| MIDMER, Richard Neil | Sekretär | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | 110640170001 | ||||||
| MORTIMER, Rachel | Sekretär | 14 Huron Road SW17 8RB London | British | 102674500002 | ||||||
| POOLEY, Maureen | Sekretär | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | English | 51896650001 | ||||||
| AUBERY, Paul Richard | Geschäftsführer | 1 Malthouse Drive Regency Quay Chiswick W4 2NR London | British | 78253140001 | ||||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | Usa | American | 94259330002 | |||||
| BERGBAUM, Arthur | Geschäftsführer | 23 Pine Grove Totteridge N20 8LB London | British | 1770100001 | ||||||
| BLITZER, David Scott | Geschäftsführer | 5 Priory Walk SW10 9SP London | England | American | 82685720001 | |||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Geschäftsführer | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| DAVIES, William Jeremy | Geschäftsführer | The Manor House Great Somerford SN15 5EH Chippenham Wiltshire | England | British | 21505070001 | |||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Geschäftsführer | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||
| ELLERT, Richard John | Geschäftsführer | Cami Del Padro 10 Sant Vicenc De Montalt Barcelona Catalonia 08394 Spain | British | 95944260001 | ||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Geschäftsführer | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||
| FRANCIS, Daniel Fernley | Geschäftsführer | Bartley Lodge 11 Marlborough Road Chandlers Ford SO53 5DJ Eastleigh Hampshire | England | British | 44830480001 | |||||
| GRANT, Michael John | Geschäftsführer | Edwill Way BR3 6RY Beckenham 73 Kent | England | British | 141668610001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | 110640170001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | 110640170001 | |||||
| MOY, Neal St John | Geschäftsführer | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 | ||||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
| NICHOLSON, Daniel Christopher | Geschäftsführer | 181 Seagrave Road SW6 1ST London | England | British | 77890230001 | |||||
| PICKERSGILL, Dominic James | Geschäftsführer | 72 Stafford Street NR2 3BG Norwich Norfolk | British | 60834690001 | ||||||
| PIKE, Chad Rustan | Geschäftsführer | 25 Burnsall Street SW3 3SR London | United Kingdom | British | 87606860002 | |||||
| POOLEY, Maureen | Geschäftsführer | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | England | English | 51896650001 | |||||
| RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 |
Hat NHP SECURITIES NO. 7 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A security deed | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 30. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2005 Geliefert am 20. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2005 Geliefert am 15. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0