FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED

FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03657772
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ground Floor, Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORDGATE ESTATES LIMITED20. Feb. 200120. Feb. 2001
    EASTER CAPITAL PORTFOLIO LIMITED10. Feb. 199910. Feb. 1999
    PRECIS (1694) LIMITED28. Okt. 199828. Okt. 1998

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2016

    8 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Canal Mill Botany Bay Chorley Lancashire PR6 9AF zum Ground Floor, Seneca House Links Point Amy Johnson Way Blackpool Lancashire FY4 2FF am 04. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Sept. 2016

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Claire Caroline Sharp als Geschäftsführer am 09. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy John Peter Knowles als Geschäftsführer am 09. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2015

    8 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2015 bis 30. Jan. 2015

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2014

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 30. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2012

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von William Dixon als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2011

    9 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed fordgate estates LIMITED\certificate issued on 02/11/10
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name02. Nov. 2010

    Beschluss zur Änderung der Firma am 30. Sept. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2010

    9 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish71862660002
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Sekretär
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    British85743480001
    JACOBS, Simon
    76 Edgwarebury Lane
    HA8 8LY Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    76 Edgwarebury Lane
    HA8 8LY Edgware
    Middlesex
    British74462020001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Sekretär
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARBER, Martin
    28 Stormont Road
    N6 4NP London
    Geschäftsführer
    28 Stormont Road
    N6 4NP London
    British35534320001
    CORAL, Lynda Sharon
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    British34029880002
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritish136501510001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritish85366800001
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish33274370003
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Geschäftsführer
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritish59962430002
    SHARP, Carrie
    The Croft Lower Simpson Fold
    Blackburn Road
    PR6 8HL Higher Wheelton Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Croft Lower Simpson Fold
    Blackburn Road
    PR6 8HL Higher Wheelton Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish124558490001
    SHARP, Claire Caroline
    Botany Bay
    PR6 9AF Chorley
    Canal Mill
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Botany Bay
    PR6 9AF Chorley
    Canal Mill
    Lancashire
    EnglandBritish141979130001
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    TAYLOR RESTELL, Ian Miles
    21 Ash Church Park Villas
    W12 9SP London
    Geschäftsführer
    21 Ash Church Park Villas
    W12 9SP London
    British56776370003
    WECHSLER, Michael
    48 Brookside Road
    NW11 9NE London
    Geschäftsführer
    48 Brookside Road
    NW11 9NE London
    EnglandBritish12071850001
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Geschäftsführer
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    British47611200001
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish110948700001

    Hat FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 09. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For details of legally mortgaged property please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutche Bank Ag as Security Trustee
    Transaktionen
    • 09. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 07. Juni 2001
    Geliefert am 08. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower (as defined) the property owners (as defined ) and /or the company to the chargee under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    The properties k/a 1-7 lynton road swinton t/n WT5533, north cheshire trading estate penton wyrall t/n MS288604.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limitedthe Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 08. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party debenture
    Erstellt am 13. Feb. 2001
    Geliefert am 22. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from sandrim holdings limited (the borrower), the property owners (as defined) and/or the company (formerly known as easter capital portfolio limited) to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) (the security trustee) from time to time under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    Units 1,2 and 3 conway street hove t/n ESX169969 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    F/H land being units 1-7 lynton road swindon t/n WT5533 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    F/H land being 11 12 and 14 (inclusive) ravenhurst court and 1-12 (inclusive) and 14,15 and 16 gawsworth court risley road risley warrington chaeshire t/n CH320470 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    All that l/h land and buildings to the south of woodchurch road birkenhead t/n MS288604 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    F/H land being unit 1 euroway estate commondale way bierley t/n WYK419929 f/h land on the east side of commondale way oakenshaw WYK105459 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    All that f/h land being land and buildings on the north east side of ashfield way farnley t/n WYK69344 all monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and portfolio limited ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    Freehold land being units 1,2,3,4 and 5 south hampshire industrial estate totton t/n HP404430 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from capital and regional properties PLC and philcap one limited and the company ("the trustee") to the chargee on any account whatsoever and all other sums incurred pursuant to the security documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    All that f/h land being land and buildings on the south east side of ripley drive normanton t/n WYK547370 with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto and with the benefit of existing and future leases underleases tenancies and agreements for lease first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FIRST ESTATES PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Sept. 2016Beginn der Liquidation
    10. Juli 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Ian Williamson
    Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire
    Praktiker
    Seneca House Links Point
    Amy Johnson Way
    FY4 2FF Blackpool
    Lancashire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0