MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03659151 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | - Mi Technology Group Holdings Ltd Aston Way PR26 7TZ Leyland, Preston Lancashire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MI TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 03. Okt. 2001 | 03. Okt. 2001 |
BROOMCO (1699) LIMITED | 29. Okt. 1998 | 29. Okt. 1998 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lee Markey als Geschäftsführer am 07. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Andrew May am 29. Sept. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr James Andrew May als Direktor am 29. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Rippin als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Joseph Falconi als Geschäftsführer am 27. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Joseph Falconi als Sekretär am 27. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Ms Kathryn Anne Yung als Direktor am 27. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Lee Markey als Direktor am 14. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Esteban De Bernardis als Geschäftsführer am 18. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse St Botolph Building 138 Houndsditch London EC3A 7AR verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf St Botolph Building 138 Houndsditch London EC3A 7AR geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ralf Edmund Schunk als Geschäftsführer am 19. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY, James Andrew | Geschäftsführer | Mi Technology Group Holdings Ltd Aston Way PR26 7TZ Leyland, Preston - Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director | 238628690001 | ||||
YUNG, Kathryn Anne | Geschäftsführer | Mi Technology Group Holdings Ltd Aston Way PR26 7TZ Leyland, Preston - Lancashire | Canada | Canadian | Managing Director | 227376130001 | ||||
FALCONI, Robert Joseph | Sekretär | Rexdale Blvd. M9W 1R3 Toronto 178 Ontario Canada | 182187880001 | |||||||
OAKES, James Ian | Sekretär | Astley Lodge Shrewsbury Road Hadnall SY4 4AE Shrewsbury | British | Company Director | 38456190002 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
ALLSOPP, Robert William | Geschäftsführer | Mi Technology Group Holdings Ltd Aston Way PR26 7TZ Leyland, Preston - Lancashire | England | United Kingdom | Company Director | 91761920001 | ||||
DE BERNARDIS, Esteban | Geschäftsführer | Rexdale Blvd. M9W 1R3 Toronto 178 Ontario Canada | Canada | Canadian / Argentinian | Executive Vp, Finance And Administration At Csa Gr | 184757410001 | ||||
DEPRAS, Magali Celine | Geschäftsführer | Weismullerstr 60314 Frankfurt 45 Germany | Germany | French | Regional Vp - Europe | 140532830001 | ||||
FALCONI, Robert Joseph | Geschäftsführer | Rexdale Blvd. M9W 1R3 Toronto 178 Ontario Canada | Canada | Canadian | Company Director | 139252830003 | ||||
FIELD, Martin John | Geschäftsführer | 4 Quarry Way Emersons Green BS16 7BN Bristol | England | British | Company Director | 57873620002 | ||||
MARKEY, Lee | Geschäftsführer | Mi Technology Group Holdings Ltd Aston Way PR26 7TZ Leyland, Preston - Lancashire | England | British | Uk Financial Controller | 218809150001 | ||||
O'LEARY, Martin | Geschäftsführer | Leyland PR26 7TZ Preston Aston Way Lancashire United Kingdom | England | British | Director/Country Manager | 188997310001 | ||||
OAKES, James Ian | Geschäftsführer | Astley Lodge Shrewsbury Road Hadnall SY4 4AE Shrewsbury | England | British | Company Director | 38456190002 | ||||
PARMENTER, Dana | Geschäftsführer | Eccleston CH4 9JN Chester Rake Lane Cheshire United Kingdom | United Kingdom | American | Managing Director | 171827180002 | ||||
RIPPIN, Ian | Geschäftsführer | Mi Technology Group Holdings Ltd Aston Way PR26 7TZ Leyland, Preston - Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director | 188997500001 | ||||
SAHI, Ash Kumar | Geschäftsführer | Rexdale Blvd. M9W 1R3 Toronto 178 Ontario Canada | Canada | Canadian | Company Director | 147506050002 | ||||
SCHUNK, Ralf Edmund | Geschäftsführer | Weismullerstr 60314 Frankfurt 45 Germany | Germany | German | Managing Director | 187347800001 | ||||
SIDERY, Gerald James | Geschäftsführer | Eccleston CH4 9JN Chester Rake Lane Cheshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 55944290002 | ||||
TAYLOR, Merrick Wentworth | Geschäftsführer | The Stables Old Milverton Lane Old Milverton CV32 6SA Leamington Spa Warwickshire | England | British | Company Director | 34255090001 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi Technology Investments Limited | 06. Apr. 2016 | Leyland PR26 7TZ Preston Aston Way Lancashire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MI TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Assignment of life policy | Erstellt am 31. Juli 2001 Geliefert am 10. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number T870189/126216 with lutine assurance services on the life of marin john field and all money payable thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of life policy | Erstellt am 31. Juli 2001 Geliefert am 10. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number T870189/126217 with lutine assurance services limited on the life of james ian oakes and all money payable thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Juli 2001 Geliefert am 10. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of keyman life policy | Erstellt am 28. Sept. 1999 Geliefert am 04. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company assigns all of its right title benefit and interest in and to the policy being policy no. T870189/126217 over james ian oakes for £250,000 (see form 395 for futher details) and all monies including bonuses accrued,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of keyman life policy | Erstellt am 28. Sept. 1999 Geliefert am 04. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company assigns all of its right title benefit and interest in and to the policy being policy no. T870198/126216 for james ian oakes for £250,000 (see form 395 for further details) and all monies including bonuses accrued,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 16. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan note documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of deposit of stocks and shares | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Securities being for the payment and discharge of the secured OBLIGATIONS32,500 ordinary shares of £1.00 each and 67,500 preferred ordinary shares of £1.o each in cherrypin limited (company no. 2899074 and all dividends interest bonsus in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0